WESTVIEW LODGE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WESTVIEW LODGE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03065402 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WESTVIEW LODGE LIMITED ?
Adresse du siège social | 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WESTVIEW LODGE LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2018 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2019 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WESTVIEW LODGE LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 juin 2021 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 21 juin 2021 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 juin 2020 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour WESTVIEW LODGE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal | 20 pages | WU07 | ||
Ordonnance du tribunal pour liquider | 3 pages | COCOMP | ||
Nomination d'un liquidateur | 3 pages | WU04 | ||
Ordonnance du tribunal pour liquider | 2 pages | COCOMP | ||
Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration | 53 pages | AM25 | ||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 41 pages | AM10 | ||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 42 pages | AM10 | ||
Avis de prolongation de la période de l'administration | 3 pages | AM19 | ||
Changement d'adresse du siège social de 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB à 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB le 12 nov. 2021 | 2 pages | AD01 | ||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 45 pages | AM10 | ||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 47 pages | AM10 | ||
Avis de prolongation de la période de l'administration | 3 pages | AM19 | ||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 47 pages | AM10 | ||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA | 10 pages | AM02 | ||
Avis d'approbation réputée des propositions | 3 pages | AM06 | ||
Changement d'adresse du siège social de Norcliffe House Station Road Wilmslow SK9 1BU à 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB le 01 avr. 2020 | 2 pages | AD01 | ||
Déclaration de la proposition de l'administrateur | 42 pages | AM03 | ||
Nomination d'un administrateur | 3 pages | AM01 | ||
Cessation de la nomination de Martin William Oliver Healy en tant que directeur le 30 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Notification de Mericourt Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 juil. 2019 | 2 pages | PSC02 | ||
Nomination de Mr Martin William Oliver Healy en tant qu'administrateur le 18 nov. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Timothy Richard William Hammond en tant que directeur le 18 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de Elli Finance (Uk) Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 avr. 2019 | 1 pages | PSC07 | ||
Qui sont les dirigeants de WESTVIEW LODGE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTISON, Abigail | Secrétaire | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188581000001 | |||||||
ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Administrateur | Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester 11th Floor | United Kingdom | British | Company Director | 184190020002 | ||||
TABERNER, Benjamin Robert | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 150511890001 | ||||
BAINES, Philip | Secrétaire | 97 Hangleton Road BN3 7GH Hove East Sussex | British | 3470830001 | ||||||
CARTER, Dianne | Secrétaire | 1 The Bench Ham Street Ham TW10 7HX Richmond Surrey | British | 46379850001 | ||||||
CROWE, Geoffrey Michael | Secrétaire | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Director | 38256680007 | |||||
KAY, Dominic Jude | Secrétaire | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | Solicitor | 145920530001 | |||||
MURPHY, John | Secrétaire | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Nursing Home Management | 26177180002 | |||||
SIZER, Graham Kevin | Secrétaire | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
MD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
ANSTEAD, Hamilton Douglas | Administrateur | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | Chief Executive | 107751890001 | |||||
CALVELEY, Peter, Dr | Administrateur | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | Ceo | 131468590001 | ||||
CHURCHLEY, Peter Knight | Administrateur | Rosevale House Woodside Lane SL4 2DW Windsor Forest Berkshire | England | British | Managing Director | 77173520001 | ||||
CROWE, Geoffrey Michael | Administrateur | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Director | 38256680007 | |||||
ELLIOTT, Graham Nicholas | Administrateur | 9 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | England | British | Company Director | 38064300002 | ||||
FITCH, William | Administrateur | Foxhall 19 Broomhill Park BT9 6JB Belfast Antrim | British | Director (Chairman) | 49478560001 | |||||
HAMMOND, Timothy Richard William | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | England | British | Company Director | 205777760001 | ||||
HEALY, Martin William Oliver | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | Irish | Accountant | 134003120002 | ||||
HEYWOOD, Anthony George | Administrateur | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | Chief Executive | 131288260001 | ||||
HOW, Alistair Maxwell | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 169139000001 | ||||
KAY, Dominic Jude | Administrateur | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | Solicitor | 145920530001 | ||||
MAXWELL, Barbara Ann | Administrateur | 17 Crieff Road SW18 2EB London | Irish | Director (Managing) | 41693200001 | |||||
MITCHELL, Nicholas John | Administrateur | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | Director | 145102120001 | ||||
MURPHY, John | Administrateur | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Nursing Home Management | 26177180002 | |||||
O'REILLY, Michael Patrick | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 40241900001 | ||||
SCOTT, Philip Henry | Administrateur | Garden View 5a Pelling Hill SL4 2LL Old Windsor Berkshire | Irish | Managing Director | 80396000001 | |||||
SIZER, Graham Kevin | Administrateur | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
SMITH, Ian Richard | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Company Director | 181082310001 | ||||
WILLIS, Graeme | Administrateur | 3 Carrwood Road SK9 5DJ Wilmslow Cheshire | British | Financial Director | 71527500002 | |||||
MD DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow Pacific House | 900005100001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WESTVIEW LODGE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mericourt Limited | 16 juil. 2019 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Elli Finance (Uk) Plc | 06 avr. 2017 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Elli Finance (Uk) Plc | 06 avr. 2016 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Four Seasons Health Care Group Limited | 06 avr. 2016 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
WESTVIEW LODGE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A security deed | Créé le 30 oct. 2006 Livré le 17 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 19 janv. 2000 Livré le 20 janv. 2000 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Brèves mentions The initial deposit, all interest, the deposit account and deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 22 avr. 1999 Livré le 24 avr. 1999 | En cours | Montant garanti All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee whether present or future, actual or contingent and whether alone, severally, or jointly as principal, guarantor, surety or otherwise and in whatever name or style | |
Brèves mentions First fixed charge on l/h premises situate at westview residential home west view road hartlepool cleveland TS24 obw. Fixed charge on all other f/h, l/h and other immovable property together with all buildings trade and other fixtures plant and machinery goodwill and uncalled capital;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 07 juil. 1997 Livré le 08 juil. 1997 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default (as defined) | |
Brèves mentions The initial deposit; all interest; the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 27 mars 1997 Livré le 05 avr. 1997 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge on l/h premises situate at west view lodge nursing home west view road hartlepool cleveland .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
WESTVIEW LODGE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In administration |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Compulsory liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0