SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03072288 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mars 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Vinotha Kamala Anthony le 01 mars 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Michael Mills en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nameeta Pai en tant que directeur le 22 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Lindiwe Pratt en tant qu'administrateur le 18 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lindiwe Pratt en tant que directeur le 12 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Lindiwe Pratt en tant qu'administrateur le 12 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kristen Alexandra Allen en tant que directeur le 12 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Statuts | 32 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Nomination de Mrs Vinotha Kamala Anthony en tant qu'administrateur le 11 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Sarah Lucy Charsley en tant qu'administrateur le 11 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew John Richardson en tant qu'administrateur le 08 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen David Affleck en tant que directeur le 08 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dionne Leigh Paula Mortley-Forde en tant que directeur le 04 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Miss Kristen Alexandra Allen en tant qu'administrateur le 03 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher James Wise en tant que directeur le 30 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Michael Mills en tant qu'administrateur le 09 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Yewande Olamide Adewuya en tant qu'administrateur le 09 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Rosamund Martha Rule en tant qu'administrateur le 09 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEWUYA, Yewande Olamide | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 297165200001 | ||||
ANTHONY, Vinotha Kamala | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Company Secretary | 313414340002 | ||||
CHARSLEY, Sarah Lucy | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Company Secretary | 313414260001 | ||||
PRATT, Lindiwe | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Chartered Governance Professional | 265729600002 | ||||
RICHARDSON, Matthew John | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 312322550001 | ||||
RULE, Rosamund Martha | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Governance Professional | 297165190001 | ||||
CAIRNS, Ian George | Secrétaire | Millwater Mill Lane GU23 6QT Ripley Surrey | British | Commercial Director | 51441470001 | |||||
CORK, Raymond Michael | Secrétaire | Kniveton DE6 1JG Ashbourne Kniveton Wood Farm | British | Accountant | 129809740001 | |||||
FRANCIS, Paul Andrew | Secrétaire | The Laurels 588 Derby Road Adams Hill NG7 2GZ Nottingham | British | Accountant | 31556620003 | |||||
HILL, Michelle Anne | Secrétaire | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | 184783830001 | |||||||
PENFOLD, Diane June | Secrétaire | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | 171688620001 | |||||||
PETRIE, Jessica Frances | Secrétaire | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | 171686270001 | |||||||
WRIGHT, Jason Leslie | Secrétaire | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | 220605620001 | |||||||
ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED | Secrétaire | 2 Triton Square Regents Place NW1 3AN London Abbey National House | 135149940001 | |||||||
ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
AFFLECK, Stephen David | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 213797030002 | ||||
ALDRED, Duncan | Administrateur | Little Timbers Village Road TW20 8UF Thorpe Surrey | British | Director | 34751970001 | |||||
ALDRED, Duncan | Administrateur | Little Timbers Village Road TW20 8UF Thorpe Surrey | British | Director | 34751970001 | |||||
ALLEN, Kristen Alexandra | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Company Secretary | 312013410001 | ||||
ANDERSON, Alexander Campbell | Administrateur | Costock Grange Farm Nottingham Road Costock LE12 6XE Loughborough Leicestershire | England | British | Director | 43710680002 | ||||
ANDERSON, Alexander Campbell | Administrateur | Costock Grange Farm Nottingham Road Costock LE12 6XE Loughborough Leicestershire | England | British | Managing Director | 43710680002 | ||||
ARBUTHNOTT, Geoffrey James | Administrateur | Lower Gustard Wood Wheathampstead AL4 8RX St Albans Lamer Hill Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 66364270001 | ||||
CAIRNS, Ian George | Administrateur | Millwater Mill Lane GU23 6QT Ripley Surrey | British | Commercial Director | 51441470001 | |||||
COCHRANE, Keith Robertson | Administrateur | Glen Hall Belwood Park PH2 7AJ Perth | British | Company Director | 47574960002 | |||||
COLES, Shaun Patrick | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 95706540002 | ||||
CORK, Raymond Michael | Administrateur | Kniveton DE6 1JG Ashbourne Kniveton Wood Farm | United Kingdom | British | Accountant | 129809740001 | ||||
DAY, William Joshua | Administrateur | 44 Humber Street Hilton DE65 5NW Derby England | England | British | Finance Director | 115995120002 | ||||
ELLIS, David James | Administrateur | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 113760650001 | ||||
ELLWOOD, Michael | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Managing Director | 162422770001 | ||||
FRANCIS, Paul Andrew | Administrateur | Apartment 18 Royal Standard House Standard Hill NG1 6FX Nottingham Nottinghamshire | England | British | Accountant | 31556620005 | ||||
GIBBS, Aurelia | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 268496460001 | ||||
GILBERT, Timothy Peter | Administrateur | Elmcroft 12 Harlaxton Drive NG7 1JA Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 79072790001 | ||||
GOODMAN, Sharon | Administrateur | Yardley Cottage Main Street, Lullington DE12 8EG Swadlincote Derbyshire | British | Accountant | 74166630001 | |||||
HILL, Michelle Anne | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Company Secretary | 185425510001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santander Uk Group Holdings Plc | 27 nov. 2018 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Santander Uk Plc | 11 juil. 2018 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Abbey National Treasury Services Plc | 06 avr. 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0