FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03074331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OMEGA (UK) LIMITED26 juin 199526 juin 1995

    Quels sont les derniers comptes de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juil. 2015

    État du capital au 23 juil. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Richard Smith le 19 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Robert Taberner le 18 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Jude Kay en tant que directeur le 28 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juil. 2014

    État du capital au 03 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Dominic Kay en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Abigail Mattison en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Maureen Claire Royston le 22 mai 2014

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* le 21 févr. 2014

    1 pagesAD01

    Nomination de Maureen Claire Royston en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Calveley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ian Richard Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    15 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188573200001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Administrateur
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Administrateur
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Administrateur
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Secrétaire
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    CMM (SECRETARIES) LIMITED
    Sceptre House
    169/173 Regent Street
    W1R 7FB London
    Secrétaire désigné
    Sceptre House
    169/173 Regent Street
    W1R 7FB London
    900004970001
    SCEPTRE CONSULTANTS LIMITED
    6 Babmaes Street
    SW1Y 6HD London
    Secrétaire
    6 Babmaes Street
    SW1Y 6HD London
    32627710003
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    BAILEY, Essel
    900 Victors Way
    Suite 350
    Ann Arbor
    Mi 48108
    Usa
    Administrateur
    900 Victors Way
    Suite 350
    Ann Arbor
    Mi 48108
    Usa
    American55075420002
    BEARDSLEY, Julian Richard
    Flat 2
    27 Moring Road
    SW17 8DN London
    Administrateur
    Flat 2
    27 Moring Road
    SW17 8DN London
    British67039610001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Administrateur
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    ELLIOTT, Graham Nicholas
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Administrateur
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    EnglandBritish38064300002
    FLAHERTY, James Paul
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    Administrateur
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    American52843400002
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Administrateur
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Administrateur
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    MAYNARD, Tanya
    14 Bayham Road
    Chiswick
    W4 1BJ London
    Administrateur
    14 Bayham Road
    Chiswick
    W4 1BJ London
    British41493210001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    NOBLE, Edward Charles
    9668 Tree Top Court
    Pickney
    FOREIGN Michigan
    Usa
    Administrateur
    9668 Tree Top Court
    Pickney
    FOREIGN Michigan
    Usa
    American69199980002
    ROBINSON, Todd Philip
    2307 Princess Ann Street
    Greensboro
    North Carolina 27408
    Usa
    Administrateur
    2307 Princess Ann Street
    Greensboro
    North Carolina 27408
    Usa
    American77491610001
    STOREY, John
    17 Collins Street
    SE3 0UG London
    Administrateur
    17 Collins Street
    SE3 0UG London
    British60123860001
    STOVER, David
    905 West Eisenhower Circle
    Suite 110
    48103 Ann Arbor Michigan
    Washtenaw County
    Usa
    Administrateur
    905 West Eisenhower Circle
    Suite 110
    48103 Ann Arbor Michigan
    Washtenaw County
    Usa
    American55075550001
    WILLIS, Graeme
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    British71527500004

    FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Scottish floating charge
    Créé le 24 nov. 2006
    Livré le 14 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First floating charge all its present and future property,assets and undertaking situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse,London Branch
    Transactions
    • 14 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A security deed
    Créé le 30 oct. 2006
    Livré le 17 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse London Branch
    Transactions
    • 17 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 janv. 2006
    Livré le 18 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rhyme debenture
    Créé le 12 nov. 2004
    Livré le 30 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Scarlet Finance Limited
    Transactions
    • 30 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A charge over bank accounts
    Créé le 03 juil. 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its rights and interests in, and all monies standing to the credit of the account by way of first fixed charge. A floating charge as further security for the payment of the indebtedness, charged with full title guarantee all its rights and interests in, and all monies stnading to the credit of, the account.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security accession deed
    Créé le 01 oct. 2002
    Livré le 16 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all freehold and leasehold property together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property; and by way of first equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclay Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transactions
    • 16 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0