FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03074331 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Norcliffe House Station Road SK9 1BU Wilmslow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Richard Smith le 19 févr. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Robert Taberner le 18 févr. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic Jude Kay en tant que directeur le 28 oct. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic Kay en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Abigail Mattison en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Maureen Claire Royston le 22 mai 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* le 21 févr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Maureen Claire Royston en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Calveley en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ian Richard Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 15 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTISON, Abigail | Secrétaire | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188573200001 | |||||||
| ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Administrateur | Alderley Road Wilmslow SK9 1NX Cheshire Emerson Court England England | United Kingdom | British | 184190020002 | |||||
| SMITH, Ian Richard | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 181082310001 | |||||
| TABERNER, Benjamin Robert | Administrateur | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 150511890001 | |||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Secrétaire | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| GOSLING, Mark David | Secrétaire | 8 Dane Close Hartlip ME9 7TN Sittingbourne Kent | British | 66801660001 | ||||||
| KAY, Dominic Jude | Secrétaire | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | 145920530001 | ||||||
| CMM (SECRETARIES) LIMITED | Secrétaire désigné | Sceptre House 169/173 Regent Street W1R 7FB London | 900004970001 | |||||||
| SCEPTRE CONSULTANTS LIMITED | Secrétaire | 6 Babmaes Street SW1Y 6HD London | 32627710003 | |||||||
| ANSTEAD, Hamilton Douglas | Administrateur | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | 107751890001 | ||||||
| BAILEY, Essel | Administrateur | 900 Victors Way Suite 350 Ann Arbor Mi 48108 Usa | American | 55075420002 | ||||||
| BEARDSLEY, Julian Richard | Administrateur | Flat 2 27 Moring Road SW17 8DN London | British | 67039610001 | ||||||
| CALVELEY, Peter, Dr | Administrateur | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | 131468590001 | |||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Administrateur | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| ELLIOTT, Graham Nicholas | Administrateur | 9 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | England | British | 38064300002 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Administrateur | 28 Harley House Marylebone Road NW1 5HF London | American | 52843400002 | ||||||
| GOSLING, Mark David | Administrateur | 8 Dane Close Hartlip ME9 7TN Sittingbourne Kent | British | 66801660001 | ||||||
| HEYWOOD, Anthony George | Administrateur | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | 131288260001 | |||||
| KAY, Dominic Jude | Administrateur | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | 145920530001 | |||||
| MAYNARD, Tanya | Administrateur | 14 Bayham Road Chiswick W4 1BJ London | British | 41493210001 | ||||||
| MITCHELL, Nicholas John | Administrateur | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | 145102120001 | |||||
| NOBLE, Edward Charles | Administrateur | 9668 Tree Top Court Pickney FOREIGN Michigan Usa | American | 69199980002 | ||||||
| ROBINSON, Todd Philip | Administrateur | 2307 Princess Ann Street Greensboro North Carolina 27408 Usa | American | 77491610001 | ||||||
| STOREY, John | Administrateur | 17 Collins Street SE3 0UG London | British | 60123860001 | ||||||
| STOVER, David | Administrateur | 905 West Eisenhower Circle Suite 110 48103 Ann Arbor Michigan Washtenaw County Usa | American | 55075550001 | ||||||
| WILLIS, Graeme | Administrateur | 4 Woodbank Lynton Lane SK9 7NP Alderley Edge Cheshire | British | 71527500004 |
FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Scottish floating charge | Créé le 24 nov. 2006 Livré le 14 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First floating charge all its present and future property,assets and undertaking situated in scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A security deed | Créé le 30 oct. 2006 Livré le 17 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 09 janv. 2006 Livré le 18 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rhyme debenture | Créé le 12 nov. 2004 Livré le 30 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A charge over bank accounts | Créé le 03 juil. 2003 Livré le 11 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due by any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its rights and interests in, and all monies standing to the credit of the account by way of first fixed charge. A floating charge as further security for the payment of the indebtedness, charged with full title guarantee all its rights and interests in, and all monies stnading to the credit of, the account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security accession deed | Créé le 01 oct. 2002 Livré le 16 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage all freehold and leasehold property together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property; and by way of first equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0