M W H DEVELOPERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM W H DEVELOPERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03076424
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M W H DEVELOPERS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe M W H DEVELOPERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    9 Highfield Park Road
    PL15 7DX Launceston
    Cornwall
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de M W H DEVELOPERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour M W H DEVELOPERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Jessica Anne Hodgetts le 17 juil. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew William Hodgetts le 17 juil. 2019

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Trehill Ashwater Beaworthy Devon EX21 5EF à 9 Highfield Park Road Launceston Cornwall PL15 7DX le 17 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2018

    12 pagesAA

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2018 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 28 févr. 2018 au 31 août 2018

    1 pagesAA01

    État du capital après une attribution d'actions au 17 mai 2018

    • Capital: GBP 46,203
    5 pagesSH01

    Comptes de micro-entité établis au 28 févr. 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2016

    5 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juil. 2015

    État du capital au 09 juil. 2015

    • Capital: GBP 46,003
    SH01

    Inscription de la charge 030764240012, créée le 24 oct. 2014

    40 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juil. 2014

    État du capital au 18 juil. 2014

    • Capital: GBP 46,003
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 030764240011 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 18 juil. 2013

    SH01

    Inscription de la charge 030764240011

    41 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de M W H DEVELOPERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HODGETTS, Jessica Anne
    Ashwater
    EX21 5EF Beaworthy
    Trehill
    Devon
    England
    Secrétaire
    Ashwater
    EX21 5EF Beaworthy
    Trehill
    Devon
    England
    177103450001
    HODGETTS, Jessica Anne
    Highfield Park Road
    PL15 7DX Launceston
    9
    Cornwall
    England
    Administrateur
    Highfield Park Road
    PL15 7DX Launceston
    9
    Cornwall
    England
    EnglandBritishHospitality139196450004
    HODGETTS, Matthew William
    Highfield Park Road
    PL15 7DX Launceston
    9
    Cornwall
    England
    Administrateur
    Highfield Park Road
    PL15 7DX Launceston
    9
    Cornwall
    England
    EnglandBritishBuilder139196440003
    HODGETTS, Michael William
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    Administrateur
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    EnglandBritishBuilder43733210005
    HODGETTS, Sarah Anne
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    Administrateur
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    EnglandBritishDirector43733220005
    HODGETTS, Sarah Anne
    Lewdown
    EX20 4BX Okehampton
    The Swallows
    Devon
    England
    Secrétaire
    Lewdown
    EX20 4BX Okehampton
    The Swallows
    Devon
    England
    BritishCompany Secretary43733220003
    BRADLEY, Terry
    Sandhill Lawn
    WF8 4JB Pontefract
    3
    West Yorkshire
    Administrateur
    Sandhill Lawn
    WF8 4JB Pontefract
    3
    West Yorkshire
    United KingdomBritishConsultant139353400001
    FERRIS, Neil James
    High Street
    DN9 1NR Belton
    47
    South Yorkshire
    Administrateur
    High Street
    DN9 1NR Belton
    47
    South Yorkshire
    EnglandBritishLocal Government Officer139353820001
    MURRAY, Alexander
    5 Shelley Way
    CH48 3LQ Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    5 Shelley Way
    CH48 3LQ Wirral
    Merseyside
    EnglandBritishDirector106524300001
    WESTLAKE, Douglas Robert Alan
    Alder Farm
    Lewdown
    EX20 4PJ Okehampton
    Devon
    Administrateur
    Alder Farm
    Lewdown
    EX20 4PJ Okehampton
    Devon
    EnglandBritishDirector18111410001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur M W H DEVELOPERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Michael William Hodgetts
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    06 avr. 2016
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mrs Sarah Anne Hodgetts
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    06 avr. 2016
    Lewdown
    EX20 4DQ Okehampton
    Jims
    Devon
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    M W H DEVELOPERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 oct. 2014
    Livré le 07 nov. 2014
    En cours
    Brève description
    31 priory close, whitchurch, tavistock, devon. T/no DN388037 freehold.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 juin 2013
    Livré le 04 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold property oakdene 60 priory close tavistock devon t/n 425247. notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 15 oct. 2012
    Livré le 18 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H jim's garden lewdown okehampton devon t/no DN622063.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 août 2012
    Livré le 04 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 janv. 2011
    Livré le 09 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    14 st john's road launceston t/no:CL278579ANY other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 07 déc. 2009
    Livré le 22 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    14 campion rise tavistock devon.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 26 août 2003
    Livré le 04 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property at hovis barn launceston. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 31 janv. 2001
    Livré le 08 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at cider house bulsworthy near launceston cornwall (f/h). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 26 févr. 1999
    Livré le 11 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Garden to the rear of church house broadwoodwidger devon. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1996
    Livré le 02 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property land at the rear of 2 central green lewdown okehampton devon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 oct. 1995
    Livré le 31 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 3 central green and adjoining land lewdon okehampton with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 oct. 1995
    Livré le 07 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0