REX JOHNSON ONLINE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | REX JOHNSON ONLINE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03078447 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit 1 Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2019 au 31 mai 2019 | 1 pages | AA01 | ||
Cessation de la nomination de Alpesh Kumar Patel en tant que directeur le 07 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Sheraz Afzal en tant qu'administrateur le 07 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Kevin Richard Kaye en tant que directeur le 22 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Alpesh Kumar Patel en tant qu'administrateur le 22 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 7 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Tony Deakin en tant que directeur le 01 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England à Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN le 12 sept. 2018 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Lorna Biondi en tant que secrétaire le 30 avr. 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Mr Tony Deakin en tant qu'administrateur le 27 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Scott Aaron Cohen en tant que directeur le 27 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA England à C/O Browne Jacobson Llp Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ | 1 pages | AD02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 7 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de 6 Bevis Marks London EC3A 7BA à Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ le 16 sept. 2016 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Eric George Erickson en tant que directeur le 08 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFZAL, Sheraz | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 251073350001 | |||||
| BIONDI, Lorna | Secrétaire | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | 196294160001 | |||||||
| FREEMAN, Lynne Ann | Secrétaire | Lakeside Litchborough Road Duncote NN12 8AL Towcester Northamptonshire | British | 52719170001 | ||||||
| MCKENZIE, Robbie | Secrétaire | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195401170001 | |||||||
| PRIOR, Mark Lee | Secrétaire | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178139140001 | |||||||
| SALKELD, Ian | Secrétaire | 30 Felstead Road Wanstead E11 2QJ London | British | 52338990001 | ||||||
| SOKOLOWSKI, Peter John | Secrétaire | 208 Rively Avenue Collingdale Pennsylvannia 19023 Usa | American | 68054300001 | ||||||
| WALTON, Caroline Debra | Secrétaire | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 58608750003 | ||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| TABSEC LIMITED | Secrétaire | Torrington House 47 Holywell Hill AL1 1HD St Albans Hertfordshire | 1677520001 | |||||||
| COHEN, Scott Aaron | Administrateur | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | United States | American | 209567180001 | |||||
| COOK, Richard Charles | Administrateur | The Cottage 8 Station Road Ivinghoe LU7 9EB Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 25254880001 | ||||||
| CORNWELL, Nicholas Grant | Administrateur | The Old Rectory Rectory Hill, Cranford St Andrews NN14 1HP Kettering Northants | United Kingdom | British | 95585590001 | |||||
| DEAKIN, Tony | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 210862440001 | |||||
| DORFMAN, Richard Seth | Administrateur | 9 Pleasant Court Medford FOREIGN Newjersey 08055 Usa | American | 67599880001 | ||||||
| ERICKSON, Eric George | Administrateur | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | Usa | 224104020001 | |||||
| GAYHARDT, Donald Francis | Administrateur | 511 Lynmere Road Brynmawr FOREIGN Pennsylvannia 19010 Usa | United States | American | 67600210001 | |||||
| HETHERINGTON, Cameron John | Administrateur | 3 Barculdie Crescent QLD 4508 Deception Bay Queensland Australia | Australian | 123428110001 | ||||||
| HIBBERD, Roy Wayne | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | Usa | United States | 158609380001 | |||||
| KAYE, Kevin Richard | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 257480610001 | |||||
| MAY, Paul Edward | Administrateur | The Old Rectory Bradden NN12 8ED Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 83046570001 | |||||
| MCLURE, Gordon Stuart Douglas | Administrateur | "The Bails" Boughton Hall Boughton NN2 8SQ Northampton | British | 39434610002 | ||||||
| MILDENSTEIN, Paul | Administrateur | The Barn Redhouse Farm Redhouse Farm Lane CV35 7NZ Beausale 2 Warwickshire | England | British | 158561370001 | |||||
| NORRIS, Terence John | Administrateur | Woodlands Dukes Covert GU19 5HU Bagshot Surrey | United Kingdom | British | 8778080001 | |||||
| PATEL, Alpesh Kumar | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 193008350001 | |||||
| PICCINI, Silvio Dante | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | American | 129300540002 | |||||
| PRIOR, Mark Lee | Administrateur | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | American | 177845480001 | |||||
| SALKELD, Ian | Administrateur | 30 Felstead Road Wanstead E11 2QJ London | British | 52338990001 | ||||||
| WEISS, Jeffrey Allan | Administrateur | Lancaster Avenue Suite 300 19312 Berwyn 1436 Usa | Usa | United States | 151303310006 | |||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash A Cheque Holdings Great Britain Limited | 06 avr. 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 Bevis Marks England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
REX JOHNSON ONLINE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit | Créé le 30 oct. 2002 Livré le 04 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All deposits now and in the future credited to account designation 8706638 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rental deposit deed | Créé le 07 avr. 2000 Livré le 13 avr. 2000 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease of even date | |
Brèves mentions All interest in the rent deposit and the account into which the rent is paid and all money from time to time withdrawn. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over credit balances | Créé le 22 févr. 2000 Livré le 03 mars 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a loan note instrument constituting £1,000,000 guaranteed loan notes 2007 dated 22 february 2000 in favour of cash-a-cheque (GB) limited | |
Brèves mentions The sum of £1,000,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8706638 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Pledge and security agreement | Créé le 15 sept. 1999 Livré le 30 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti The payment and performance of its obligations due or to become due from the company to the chargee under the guaranty and guarantor security agreement | |
Brèves mentions All shares in the company all voting and non-voting rights of shares and all cash and non-cash dividends and all other property chattels contracts intangible goods of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 05 mars 1997 Livré le 12 mars 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0