REX JOHNSON ONLINE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREX JOHNSON ONLINE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03078447
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 1 Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CASH-A-CHEQUE (GB) LIMITED08 sept. 199508 sept. 1995
    WORDPOINT LIMITED11 juil. 199511 juil. 1995

    Quels sont les derniers comptes de REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2019 au 31 mai 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Alpesh Kumar Patel en tant que directeur le 07 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Sheraz Afzal en tant qu'administrateur le 07 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Kevin Richard Kaye en tant que directeur le 22 mars 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alpesh Kumar Patel en tant qu'administrateur le 22 mars 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tony Deakin en tant que directeur le 01 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England à Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN le 12 sept. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Lorna Biondi en tant que secrétaire le 30 avr. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Tony Deakin en tant qu'administrateur le 27 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Scott Aaron Cohen en tant que directeur le 27 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA England à C/O Browne Jacobson Llp Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 6 Bevis Marks London EC3A 7BA à Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ le 16 sept. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Eric George Erickson en tant que directeur le 08 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AFZAL, Sheraz
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish251073350001
    BIONDI, Lorna
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Secrétaire
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    196294160001
    FREEMAN, Lynne Ann
    Lakeside Litchborough Road
    Duncote
    NN12 8AL Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Lakeside Litchborough Road
    Duncote
    NN12 8AL Towcester
    Northamptonshire
    British52719170001
    MCKENZIE, Robbie
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    195401170001
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    178139140001
    SALKELD, Ian
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    Secrétaire
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    British52338990001
    SOKOLOWSKI, Peter John
    208 Rively Avenue
    Collingdale
    Pennsylvannia 19023
    Usa
    Secrétaire
    208 Rively Avenue
    Collingdale
    Pennsylvannia 19023
    Usa
    American68054300001
    WALTON, Caroline Debra
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Secrétaire
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    British58608750003
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    TABSEC LIMITED
    Torrington House 47 Holywell Hill
    AL1 1HD St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Torrington House 47 Holywell Hill
    AL1 1HD St Albans
    Hertfordshire
    1677520001
    COHEN, Scott Aaron
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Administrateur
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    United StatesAmerican209567180001
    COOK, Richard Charles
    The Cottage 8 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Cottage 8 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British25254880001
    CORNWELL, Nicholas Grant
    The Old Rectory
    Rectory Hill, Cranford St Andrews
    NN14 1HP Kettering
    Northants
    Administrateur
    The Old Rectory
    Rectory Hill, Cranford St Andrews
    NN14 1HP Kettering
    Northants
    United KingdomBritish95585590001
    DEAKIN, Tony
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish210862440001
    DORFMAN, Richard Seth
    9 Pleasant Court
    Medford
    FOREIGN Newjersey 08055
    Usa
    Administrateur
    9 Pleasant Court
    Medford
    FOREIGN Newjersey 08055
    Usa
    American67599880001
    ERICKSON, Eric George
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaUsa224104020001
    GAYHARDT, Donald Francis
    511 Lynmere Road
    Brynmawr
    FOREIGN Pennsylvannia 19010
    Usa
    Administrateur
    511 Lynmere Road
    Brynmawr
    FOREIGN Pennsylvannia 19010
    Usa
    United StatesAmerican67600210001
    HETHERINGTON, Cameron John
    3 Barculdie Crescent
    QLD 4508 Deception Bay
    Queensland
    Australia
    Administrateur
    3 Barculdie Crescent
    QLD 4508 Deception Bay
    Queensland
    Australia
    Australian123428110001
    HIBBERD, Roy Wayne
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    UsaUnited States158609380001
    KAYE, Kevin Richard
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish257480610001
    MAY, Paul Edward
    The Old Rectory
    Bradden
    NN12 8ED Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Bradden
    NN12 8ED Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish83046570001
    MCLURE, Gordon Stuart Douglas
    "The Bails" Boughton Hall
    Boughton
    NN2 8SQ Northampton
    Administrateur
    "The Bails" Boughton Hall
    Boughton
    NN2 8SQ Northampton
    British39434610002
    MILDENSTEIN, Paul
    The Barn Redhouse Farm
    Redhouse Farm Lane
    CV35 7NZ Beausale
    2
    Warwickshire
    Administrateur
    The Barn Redhouse Farm
    Redhouse Farm Lane
    CV35 7NZ Beausale
    2
    Warwickshire
    EnglandBritish158561370001
    NORRIS, Terence John
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish8778080001
    PATEL, Alpesh Kumar
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish193008350001
    PICCINI, Silvio Dante
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandAmerican129300540002
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaAmerican177845480001
    SALKELD, Ian
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    Administrateur
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    British52338990001
    WEISS, Jeffrey Allan
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    Administrateur
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    UsaUnited States151303310006
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REX JOHNSON ONLINE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cash A Cheque Holdings Great Britain Limited
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6 Bevis Marks
    England
    06 avr. 2016
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6 Bevis Marks
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementRegister Of Uk Companies, Companies House
    Numéro d'enregistrement03449905
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    REX JOHNSON ONLINE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 30 oct. 2002
    Livré le 04 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 8706638 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed
    Créé le 07 avr. 2000
    Livré le 13 avr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease of even date
    Brèves mentions
    All interest in the rent deposit and the account into which the rent is paid and all money from time to time withdrawn.
    Personnes ayant droit
    • Imperial Cancer Research Fund
    Transactions
    • 13 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over credit balances
    Créé le 22 févr. 2000
    Livré le 03 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a loan note instrument constituting £1,000,000 guaranteed loan notes 2007 dated 22 february 2000 in favour of cash-a-cheque (GB) limited
    Brèves mentions
    The sum of £1,000,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8706638 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge and security agreement
    Créé le 15 sept. 1999
    Livré le 30 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment and performance of its obligations due or to become due from the company to the chargee under the guaranty and guarantor security agreement
    Brèves mentions
    All shares in the company all voting and non-voting rights of shares and all cash and non-cash dividends and all other property chattels contracts intangible goods of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank National Association, as Administrative Agent for Itself and the Lenders (Asdefined)
    Transactions
    • 30 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 mars 1997
    Livré le 12 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0