SOLUS (LONDON) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SOLUS (LONDON) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03078842 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOLUS (LONDON) LIMITED ?
Adresse du siège social | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOLUS (LONDON) LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SOLUS (LONDON) LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SOLUS (LONDON) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Nomination de Ms Kerry Anne Chilvers en tant qu'administrateur le 04 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ms Rebecca Mary Brown en tant qu'administrateur le 14 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Finbar Peter Conway en tant qu'administrateur le 14 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr John Thomas Lyons en tant qu'administrateur le 14 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de James Robert Sturman en tant que directeur le 31 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Annarien Adams en tant que directeur le 03 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 45 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Aviva Company Secretarial Services Limited le 27 mars 2024 | 1 pages | CH04 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Robert Sturman le 27 mars 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Forder Pond en tant que directeur le 23 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr James Robert Sturman en tant qu'administrateur le 01 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 43 pages | AA | ||
Nomination de Mr Peter Edward Reilly en tant qu'administrateur le 02 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Nicola Anne Green en tant que directeur le 18 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Jonathan Mark Santer en tant qu'administrateur le 09 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 43 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Waseem Ullah Malik en tant qu'administrateur le 15 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de David John Lovely en tant que directeur le 22 nov. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 43 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Louise Mary Kirkbride en tant que directeur le 08 sept. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Nicola Anne Green en tant qu'administrateur le 08 sept. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Adam Hiscocks en tant que directeur le 16 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de SOLUS (LONDON) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom |
| 1278390005 | ||||||||||
BROWN, Rebecca Mary | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 328556200001 | ||||||||
CHILVERS, Kerry Anne | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 274844910001 | ||||||||
CONWAY, Finbar Peter | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 295605550001 | ||||||||
LYONS, John Thomas | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 328515550001 | ||||||||
MALIK, Waseem Ullah | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 224364480001 | ||||||||
REILLY, Peter Edward | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | Scotland | British | Director | 187016490001 | ||||||||
SANTER, Jonathan Mark | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 302544740001 | ||||||||
SMITH, Simon Andrew | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 163681550003 | ||||||||
DIONISIOU, Dean | Secrétaire | 105, Lancaster Avenue EN4 0ES Cockfosters Hertfordshire | British | 116307160001 | ||||||||||
HOBSON, Stephen Ronald | Secrétaire | Gwenfro Windmill Lane Barnet Lane EN5 3HX Arkley Hertfordshire | British | Director | 45169730004 | |||||||||
LUXTON, Ian John | Secrétaire | 5 Sheridan Grange Sunningdale SL5 0BX Ascot Berkshire | British | 44667020002 | ||||||||||
ACCESS REGISTRARS LIMITED | Secrétaire désigné | International House 31 Church Road Hendon NW4 4EB London | 900011510001 | |||||||||||
ADAMS, Annarien | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | South African | Director | 282235750001 | ||||||||
ALDREN, Marcus Ashley | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Insurance Company Official | 150398390001 | ||||||||
BRADLEY, John Charles | Administrateur | Troy House Troy Lane OX5 3HA Kirtlington Oxfordshire | England | British | Company Director | 66631860001 | ||||||||
CALDWELL, Alexander | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Insurance Company Official | 158816260001 | ||||||||
CLAYBROOK, Fiona Elizabeth Anne | Administrateur | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 Norfolk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 183574790001 | ||||||||
CLAYDEN, Dominic John | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Insurance Company Official | 183858000001 | ||||||||
COPPING, Teresa Christine | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | Uk | British | Insurance Company Official | 150399150001 | ||||||||
DEAKIN, Janice | Administrateur | Field Barn Broad Road IP20 0AZ Alburgh Norfolk | England | British | Company Director | 238355920001 | ||||||||
DIONISIOU, George | Administrateur | 53a Marlborough Place St Johns Wood NW8 0PS London | England | British | Company Director | 51918710002 | ||||||||
EGAN, Scott | Administrateur | 18 Broadmead Green Thorpe End NR13 5DE Norwich | British | Insurance Company Official | 111697420001 | |||||||||
EGAN, Sean | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | England | Irish | Insurance Company Official | 192694110001 | ||||||||
EGAN, Sean | Administrateur | 19 Prior Park Buildings BA2 4NP Bath | United Kingdom | Irish | Insurance Company Official | 74137500002 | ||||||||
FLORENCE, Robert | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Insurance Company Official | 114624750001 | ||||||||
GREEN, Nicola Anne | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 287481550001 | ||||||||
HISCOCKS, Richard Adam | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director Of Casualty And Motor Claims | 247474070001 | ||||||||
HOBSON, Stephen Ronald | Administrateur | Gwenfro Windmill Lane Barnet Lane EN5 3HX Arkley Hertfordshire | British | Director | 45169730004 | |||||||||
HUNT, Jacqueline | Administrateur | Oakside Cottage Norwich Road, Hethersett NR9 3DE Norwich | British | Insurance Company Official | 117817070002 | |||||||||
KIRKBRIDE, Louise Mary | Administrateur | 8 Surrey Street Norwich NR1 3NG Norfolk | United Kingdom | British | Director | 277943380001 | ||||||||
LOVELY, David John | Administrateur | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 Norfolk United Kingdom | United Kingdom | American | Director | 282878970001 | ||||||||
LOVELY, David John | Administrateur | Surrey Street NR1 3NG Norwich 8 Norfolk United Kingdom | United Kingdom | American | Global Claims Director, Aviva Gi | 195754990001 | ||||||||
LUXTON, Ian John | Administrateur | 5 Sheridan Grange Sunningdale SL5 0BX Ascot Berkshire | England | British | Chartered Accountant | 44667020002 | ||||||||
MACHELL, Simon Christopher | Administrateur | Gooch's Farm Rushall IP21 4QB Diss Norfolk | British | Chartered Accountant | 145338560001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOLUS (LONDON) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Insurance Limited | 06 avr. 2016 | PH2 0NH Perth Pitheavlis Perthshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SOLUS (LONDON) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Créé le 17 nov. 2005 Livré le 24 nov. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti £70,000.00 due or to become due from the company to | |
Brèves mentions The balance from time to time of a rent deposit of £70,000.00. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 17 sept. 2004 Livré le 05 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 28 févr. 2003 Livré le 08 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage the property k/a unit 11 whitney road daneshill industrial estate basingstoke. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 18 mai 2001 Livré le 31 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The l/h property k/a unit 16 longmead business park blenheim road epsom surrey. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 02 juin 1997 Livré le 05 juin 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0