SOLUS (LONDON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOLUS (LONDON) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03078842
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    • Entretien et réparation de véhicules automobiles (45200) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARSTAR AUTOMOTIVE LIMITED12 juil. 199512 juil. 1995

    Quels sont les derniers comptes de SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Ms Kerry Anne Chilvers en tant qu'administrateur le 04 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Rebecca Mary Brown en tant qu'administrateur le 14 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Finbar Peter Conway en tant qu'administrateur le 14 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Thomas Lyons en tant qu'administrateur le 14 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Robert Sturman en tant que directeur le 31 juil. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Annarien Adams en tant que directeur le 03 mai 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    45 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Aviva Company Secretarial Services Limited le 27 mars 2024

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Robert Sturman le 27 mars 2024

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Stephen Forder Pond en tant que directeur le 23 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr James Robert Sturman en tant qu'administrateur le 01 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    43 pagesAA

    Nomination de Mr Peter Edward Reilly en tant qu'administrateur le 02 oct. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicola Anne Green en tant que directeur le 18 août 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jonathan Mark Santer en tant qu'administrateur le 09 nov. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    43 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Waseem Ullah Malik en tant qu'administrateur le 15 mars 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Lovely en tant que directeur le 22 nov. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    43 pagesAA

    Cessation de la nomination de Louise Mary Kirkbride en tant que directeur le 08 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Nicola Anne Green en tant qu'administrateur le 08 sept. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Adam Hiscocks en tant que directeur le 16 juin 2021

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fenchurch Street
    EC3M 4AE London
    80
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 4AE London
    80
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2084205
    1278390005
    BROWN, Rebecca Mary
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector328556200001
    CHILVERS, Kerry Anne
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector274844910001
    CONWAY, Finbar Peter
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector295605550001
    LYONS, John Thomas
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector328515550001
    MALIK, Waseem Ullah
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector224364480001
    REILLY, Peter Edward
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    ScotlandBritishDirector187016490001
    SANTER, Jonathan Mark
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector302544740001
    SMITH, Simon Andrew
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector163681550003
    DIONISIOU, Dean
    105, Lancaster Avenue
    EN4 0ES Cockfosters
    Hertfordshire
    Secrétaire
    105, Lancaster Avenue
    EN4 0ES Cockfosters
    Hertfordshire
    British116307160001
    HOBSON, Stephen Ronald
    Gwenfro
    Windmill Lane Barnet Lane
    EN5 3HX Arkley
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Gwenfro
    Windmill Lane Barnet Lane
    EN5 3HX Arkley
    Hertfordshire
    BritishDirector45169730004
    LUXTON, Ian John
    5 Sheridan Grange
    Sunningdale
    SL5 0BX Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    5 Sheridan Grange
    Sunningdale
    SL5 0BX Ascot
    Berkshire
    British44667020002
    ACCESS REGISTRARS LIMITED
    International House
    31 Church Road Hendon
    NW4 4EB London
    Secrétaire désigné
    International House
    31 Church Road Hendon
    NW4 4EB London
    900011510001
    ADAMS, Annarien
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomSouth AfricanDirector282235750001
    ALDREN, Marcus Ashley
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official150398390001
    BRADLEY, John Charles
    Troy House
    Troy Lane
    OX5 3HA Kirtlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Troy House
    Troy Lane
    OX5 3HA Kirtlington
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director66631860001
    CALDWELL, Alexander
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official158816260001
    CLAYBROOK, Fiona Elizabeth Anne
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector183574790001
    CLAYDEN, Dominic John
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official183858000001
    COPPING, Teresa Christine
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    UkBritishInsurance Company Official150399150001
    DEAKIN, Janice
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    Administrateur
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director238355920001
    DIONISIOU, George
    53a Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PS London
    Administrateur
    53a Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PS London
    EnglandBritishCompany Director51918710002
    EGAN, Scott
    18 Broadmead Green
    Thorpe End
    NR13 5DE Norwich
    Administrateur
    18 Broadmead Green
    Thorpe End
    NR13 5DE Norwich
    BritishInsurance Company Official111697420001
    EGAN, Sean
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    EnglandIrishInsurance Company Official192694110001
    EGAN, Sean
    19 Prior Park Buildings
    BA2 4NP Bath
    Administrateur
    19 Prior Park Buildings
    BA2 4NP Bath
    United KingdomIrishInsurance Company Official74137500002
    FLORENCE, Robert
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official114624750001
    GREEN, Nicola Anne
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector287481550001
    HISCOCKS, Richard Adam
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector Of Casualty And Motor Claims247474070001
    HOBSON, Stephen Ronald
    Gwenfro
    Windmill Lane Barnet Lane
    EN5 3HX Arkley
    Hertfordshire
    Administrateur
    Gwenfro
    Windmill Lane Barnet Lane
    EN5 3HX Arkley
    Hertfordshire
    BritishDirector45169730004
    HUNT, Jacqueline
    Oakside Cottage
    Norwich Road, Hethersett
    NR9 3DE Norwich
    Administrateur
    Oakside Cottage
    Norwich Road, Hethersett
    NR9 3DE Norwich
    BritishInsurance Company Official117817070002
    KIRKBRIDE, Louise Mary
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    Administrateur
    8 Surrey Street
    Norwich
    NR1 3NG Norfolk
    United KingdomBritishDirector277943380001
    LOVELY, David John
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomAmericanDirector282878970001
    LOVELY, David John
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomAmericanGlobal Claims Director, Aviva Gi195754990001
    LUXTON, Ian John
    5 Sheridan Grange
    Sunningdale
    SL5 0BX Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    5 Sheridan Grange
    Sunningdale
    SL5 0BX Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant44667020002
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    BritishChartered Accountant145338560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOLUS (LONDON) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    PH2 0NH Perth
    Pitheavlis
    Perthshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    PH2 0NH Perth
    Pitheavlis
    Perthshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc002116
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SOLUS (LONDON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 17 nov. 2005
    Livré le 24 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £70,000.00 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    The balance from time to time of a rent deposit of £70,000.00.
    Personnes ayant droit
    • Tekram Properties Limited
    Transactions
    • 24 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 sept. 2004
    Livré le 05 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 05 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 08 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the property k/a unit 11 whitney road daneshill industrial estate basingstoke. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 mai 2001
    Livré le 31 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a unit 16 longmead business park blenheim road epsom surrey. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 juin 1997
    Livré le 05 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0