HAMMOND BRIDGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHAMMOND BRIDGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03082707
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HAMMOND BRIDGE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HAMMOND BRIDGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    142b Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    Oxon
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HAMMOND BRIDGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROUDLOCAL LIMITED21 juil. 199521 juil. 1995

    Quels sont les derniers comptes de HAMMOND BRIDGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour HAMMOND BRIDGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2020

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2019

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Monique Louis en tant que directeur le 01 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Monique Louis en tant qu'administrateur le 01 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 140 Eastern Avenue Milton Park, Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SB England à 142B Park Drive Milton Park Abingdon Oxon OX14 4SE le 04 oct. 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Mark Jozsef Lagler en tant qu'administrateur le 01 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gregory Davidson-Shrine en tant que directeur le 01 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gregory Davidson-Shrine en tant que secrétaire le 01 oct. 2019

    1 pagesTM02

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 06 sept. 2019

    • Capital: GBP 1
    14 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2018

    17 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Restated facility agreement and related documents / company business 05/07/2019
    RES13

    Cessation de la nomination de Andrew Wilson en tant que directeur le 31 mai 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Adrian Crookes en tant que directeur le 30 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Craig Lewendon en tant que directeur le 12 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Adrian Crookes en tant qu'administrateur le 12 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2017

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HAMMOND BRIDGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAGLER, Mark Jozsef
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    United KingdomBritish227904200001
    MARTIN, Neil Thomas George
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    United KingdomBritish126681070006
    DAVIDSON-SHRINE, Gregory
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Secrétaire
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    234770870001
    ELSEY, Robert David
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    Secrétaire
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    British44433580001
    GAHAN, Michael William
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    Secrétaire
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    British182707860001
    JARRETT, Susan Lynne
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    Secrétaire
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    British54448350001
    MARRINER, Stuart Steven
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Secrétaire
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    168621380001
    STAFFORD, Robert Simeon
    4 Clifton Wood Crescent
    Clifton Wood
    BS8 4TU Bristol
    Secrétaire
    4 Clifton Wood Crescent
    Clifton Wood
    BS8 4TU Bristol
    British77214360002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNETT, Mark William
    Old Meadows Farm
    Fowlswick Lane, Allington
    SN14 6LT Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Old Meadows Farm
    Fowlswick Lane, Allington
    SN14 6LT Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish78407520002
    BAUERNFEIND, David Gregory
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    United KingdomBritish99529910002
    BUNTING, Jonathan Michael
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish115232260002
    CADDELL, Joseph
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish115479170002
    CASHMORE, Mark Richard
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish115657470004
    COOK, Kevin Nigel
    4 Sandcroft Avenue
    BS23 4SS Weston Super Mare
    North Somerset
    Administrateur
    4 Sandcroft Avenue
    BS23 4SS Weston Super Mare
    North Somerset
    British86627710001
    CROOKES, Adrian
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish174571650001
    DAVIDSON-SHRINE, Gregory
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish169072790002
    DIBBEN, Kenneth Francis
    Naish Priory
    East Coker
    BA22 9HQ Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    Naish Priory
    East Coker
    BA22 9HQ Yeovil
    Somerset
    British14097180001
    DIXON, Nigel Anthony
    Manor Farm House
    SP4 0JZ Porton
    Wiltshire
    Administrateur
    Manor Farm House
    SP4 0JZ Porton
    Wiltshire
    EnglandBritish92047990001
    ELSEY, Robert David
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    Administrateur
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish44433580001
    ELSEY, Robert David
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    Administrateur
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish44433580001
    GAHAN, Michael William
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    Administrateur
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    United KingdomBritish182707860001
    GAYLER, David Richard
    Grey Gables
    GL7 4HD Kempsford
    Gloucestershire
    Administrateur
    Grey Gables
    GL7 4HD Kempsford
    Gloucestershire
    British4759540001
    GEORGE, Dudley Robert Charles
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    Administrateur
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    British44433600001
    GEORGE, Dudley Robert Charles
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    Administrateur
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    British44433600001
    GOULD, Jeffrey Richard
    4 Hobbs Hill
    Keevil
    BA14 6LR Trowbridge
    Wiltshire
    Administrateur
    4 Hobbs Hill
    Keevil
    BA14 6LR Trowbridge
    Wiltshire
    British45469620001
    GRESHAM, Nicholas John
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    United KingdomBritish91773790002
    JARRETT, Susan Lynne
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    Administrateur
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    British54448350001
    KERSHAW, John Graham Christopher
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish165578560001
    LAMMING, Richard, Professor
    26 Bath Road
    Beckington
    BA11 6SL Frome
    Administrateur
    26 Bath Road
    Beckington
    BA11 6SL Frome
    United KingdomBritish46380760002
    LEECH, Glenn Peter
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish131999190002
    LEWENDON, Craig Stuart
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish234768920001
    LOUIS, Monique
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    EnglandBritish238289490001
    PALMER, Matthew James
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish149814290001
    POTTER, Brian Geoffrey
    Cote Bank
    65a Bristol Road Lower
    BS23 2TL Weston Super Mare
    Somerset
    Administrateur
    Cote Bank
    65a Bristol Road Lower
    BS23 2TL Weston Super Mare
    Somerset
    British72749380002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HAMMOND BRIDGE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hedgelane Limited
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    England
    06 avr. 2016
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06470133
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HAMMOND BRIDGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 2004
    Livré le 16 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the south west side of hammond way trowbridge t/n WT85869. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 nov. 2004
    Livré le 16 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 mai 2002
    Livré le 28 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 28 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land/blds on south west side of hammond way trowbridge wiltshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 nov. 1995
    Livré le 09 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 nov. 1995
    Livré le 07 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wiltshire County Council and Others
    Transactions
    • 07 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0