GUILD VENTURES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGUILD VENTURES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03101762
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GUILD VENTURES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GUILD VENTURES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GUILD VENTURES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour GUILD VENTURES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Clement Kay en tant que directeur le 23 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Clement Kay le 10 déc. 2019

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    12 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Lorimer Widders le 05 juin 2017

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 sept. 2015

    État du capital au 28 sept. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mrs Anne Kelleher en tant que secrétaire le 26 août 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Joanne Patel en tant que secrétaire le 26 août 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    12 pagesAA

    Nomination de Mrs Joanne Patel en tant que secrétaire le 05 févr. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John David Holden en tant que secrétaire le 05 févr. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 sept. 2014

    État du capital au 24 sept. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de GUILD VENTURES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KELLEHER, Anne
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    200496230001
    HEMMINGS, Patrick Lee
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector70478960002
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    EnglandBritishDirector2272770002
    HOLDEN, John David
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    BritishChartered Accountant137210330001
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Secrétaire
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    BritishCompany Director27891540001
    PATEL, Joanne
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    194751650001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Secrétaire
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    British83024660001
    STOTT, Stjohn
    8 Broadwood Drive
    Fulwood
    PR2 4SS Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    8 Broadwood Drive
    Fulwood
    PR2 4SS Preston
    Lancashire
    British35630080001
    TIMMS, Fiona Christine
    83 St Annes Road
    Leyland
    PR5 2XR Preston
    Secrétaire
    83 St Annes Road
    Leyland
    PR5 2XR Preston
    BritishAccountant54305280003
    WILLIAMS, Joanne Fleur
    48 Kingswood Road
    PR25 2UN Leyland
    Lancashire
    Secrétaire
    48 Kingswood Road
    PR25 2UN Leyland
    Lancashire
    British95829210001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director180952730001
    HEMMINGS, Peter Graham
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector16512550010
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritishCompany Director65090920001
    KAY, John Clement
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishDirector187542370003
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Administrateur
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director27891540001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    BritishDirector32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Administrateur
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritishDirector83024660001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director2272770002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GUILD VENTURES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ensco 1057 Limited
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    England
    06 avr. 2016
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleEngland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GUILD VENTURES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 févr. 2009
    Livré le 09 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties or Any Person Appointed as Security Trustee from Time to Time in Accordance Withe the Terms of the Facility Agreement
    Transactions
    • 09 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental share charge
    Créé le 31 mai 2001
    Livré le 08 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from any member of the charging group to all or any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Charged in favour of the security tustee by way of fixed first charge 2,000,000 ordinary shares of 20 pence each in scottish & newcastle PLC together with all shares and other securities in scottish & newcastle PLC and hilton group PLC which may after the date of the charge belong to the company, including all rights, title and interest together with any substituted shares or other securities and all allotments, accretations, offers, voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 08 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 18 mars 1998
    Livré le 26 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (the "charging group") to the chargee under the terms of any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    9 million ordinary shares of 10 pence each in ladbroke group PLC and all related rights thereto and thereof including dividendsa conversion redemption bunus prference option or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 26 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 25 févr. 1998
    Livré le 02 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations of the charging group (as defined) to the chargee (as agent and trustee for the secured parties) and to all or any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    5,150,000 ordinary shares of 20 pence each in scottish & newcastle PLC including all right title and interest to such shares or other securities or all allottments accretions offers voting or other rights see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any member of the charging group (as defined in the loan agreement dated 28TH september 1993) to the chargee pursuant to the financing documents (as defined in the said loan agreement)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined Therein)
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0