GUILD VENTURES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GUILD VENTURES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03101762 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GUILD VENTURES LIMITED ?
Adresse du siège social | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GUILD VENTURES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour GUILD VENTURES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Clement Kay en tant que directeur le 23 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Clement Kay le 10 déc. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2019 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2018 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2017 | 12 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Lorimer Widders le 05 juin 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2016 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Anne Kelleher en tant que secrétaire le 26 août 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanne Patel en tant que secrétaire le 26 août 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2015 | 12 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Joanne Patel en tant que secrétaire le 05 févr. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John David Holden en tant que secrétaire le 05 févr. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GUILD VENTURES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELLEHER, Anne | Secrétaire | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | 200496230001 | |||||||
HEMMINGS, Patrick Lee | Administrateur | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 70478960002 | ||||
WIDDERS, Mark Lorimer | Administrateur | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Dower House Lancashire England | England | British | Director | 2272770002 | ||||
HOLDEN, John David | Secrétaire | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | British | Chartered Accountant | 137210330001 | |||||
KAY, John Clement | Secrétaire | 7 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | British | Company Director | 27891540001 | |||||
PATEL, Joanne | Secrétaire | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | 194751650001 | |||||||
STOTT, St John | Secrétaire | 17 Uplands Chase Fulwood PR2 7AW Preston | British | 83024660001 | ||||||
STOTT, Stjohn | Secrétaire | 8 Broadwood Drive Fulwood PR2 4SS Preston Lancashire | British | 35630080001 | ||||||
TIMMS, Fiona Christine | Secrétaire | 83 St Annes Road Leyland PR5 2XR Preston | British | Accountant | 54305280003 | |||||
WILLIAMS, Joanne Fleur | Secrétaire | 48 Kingswood Road PR25 2UN Leyland Lancashire | British | 95829210001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
HEMMINGS, Craig John | Administrateur | Charnock House Preston Road Charnock Richard PR7 5LH Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 180952730001 | ||||
HEMMINGS, Peter Graham | Administrateur | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 16512550010 | ||||
HEMMINGS, Trevor James | Administrateur | The Penthouse Retraite De La Mielle Route De La Haule St Brelade JE3 8BA Jersey Channel Islands | United Kingdom | British | Company Director | 65090920001 | ||||
KAY, John Clement | Administrateur | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | England | British | Director | 187542370003 | ||||
KAY, John Clement | Administrateur | 7 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | Company Director | 27891540001 | ||||
PENROSE, Ian Richard | Administrateur | 17 Chaucer Close Eccleston PR7 5UJ Chorley Lancashire | British | Director | 32311080001 | |||||
STOTT, St John | Administrateur | 17 Uplands Chase Fulwood PR2 7AW Preston | United Kingdom | British | Director | 83024660001 | ||||
WIDDERS, Mark Lorimer | Administrateur | 12 Clovelly Drive Hillside PR8 3AJ Southport Merseyside | England | British | Company Director | 2272770002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GUILD VENTURES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensco 1057 Limited | 06 avr. 2016 | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
GUILD VENTURES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 27 févr. 2009 Livré le 09 mars 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental share charge | Créé le 31 mai 2001 Livré le 08 juin 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies obligations and liabilities due or to become due from any member of the charging group to all or any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions Charged in favour of the security tustee by way of fixed first charge 2,000,000 ordinary shares of 20 pence each in scottish & newcastle PLC together with all shares and other securities in scottish & newcastle PLC and hilton group PLC which may after the date of the charge belong to the company, including all rights, title and interest together with any substituted shares or other securities and all allotments, accretations, offers, voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share charge | Créé le 18 mars 1998 Livré le 26 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (the "charging group") to the chargee under the terms of any of the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions 9 million ordinary shares of 10 pence each in ladbroke group PLC and all related rights thereto and thereof including dividendsa conversion redemption bunus prference option or otherwise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share charge | Créé le 25 févr. 1998 Livré le 02 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti The actual contingent present and/or future obligations of the charging group (as defined) to the chargee (as agent and trustee for the secured parties) and to all or any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions 5,150,000 ordinary shares of 20 pence each in scottish & newcastle PLC including all right title and interest to such shares or other securities or all allottments accretions offers voting or other rights see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 29 mars 1996 Livré le 10 avr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due by any member of the charging group (as defined in the loan agreement dated 28TH september 1993) to the chargee pursuant to the financing documents (as defined in the said loan agreement) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0