LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED

LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03103621
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MABLAW 331 LIMITED19 sept. 199519 sept. 1995

    Quels sont les derniers comptes de LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    25 pagesLIQ14

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    14 pagesLIQ10

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 sept. 2018

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 sept. 2017

    13 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Freeths Llp Routeco Office Park Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ England à Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva Lutterworth Leicestershire LE17 5FB le 04 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    9 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 16 sept. 2016

    LRESEX

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 20 Bentley Priory Mansion House Drive Stanmore HA7 3FB

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 20 Bentley Priory Mansion House Drive Stanmore HA7 3FB

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 61 Nascot Wood Road Watford WD17 4SJ à C/O Freeths Llp Routeco Office Park Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ le 03 août 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 juin 2016

    État du capital au 22 juin 2016

    • Capital: GBP 25,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Silbury Court 420 Silbury Boulevard Central Milton Keynes Buckinghamshire MK9 2AF à 61 Nascot Wood Road Watford WD17 4SJ le 20 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juin 2015

    État du capital au 01 juin 2015

    • Capital: GBP 25,000
    SH01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 déc. 2013 au 29 déc. 2013

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2013 au 30 déc. 2013

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 juin 2014

    État du capital au 26 juin 2014

    • Capital: GBP 25,000
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Gareth Thomas en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gareth Thomas en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NORTH, Clifford Douglas Robson, Dr
    61 Nascot Wood Road
    WD17 4SJ Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    61 Nascot Wood Road
    WD17 4SJ Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChemical Engineer24150370001
    THOMAS, Gareth
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    BritishSales Manager24150380002
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    CRAWLEY, John Henry
    81 The Grove
    BR4 9LA West Wickham
    Kent
    Administrateur
    81 The Grove
    BR4 9LA West Wickham
    Kent
    EnglandBritishGeneral Manager45868090001
    THOMAS, Gareth
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishSales Manager24150380002
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    MABLAW NOMINEES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303350001

    LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 sept. 2009
    Livré le 23 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gareth Thomas
    Transactions
    • 23 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 06 avr. 2000
    Livré le 08 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 avr. 2000
    Livré le 06 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on the remainder of company's property
    Créé le 14 mars 2000
    Livré le 15 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under the agreement or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other trade debts and floating charge on proceeds of other trade debts.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transactions
    • 15 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2000
    Livré le 16 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dr Clifford Douglas Robson North and Gareth Thomas
    Transactions
    • 16 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 25 févr. 2000
    Livré le 07 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 being all monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter (as defined)
    Brèves mentions
    Beamax calibrator pc 106 and accessories per order lps/97/0776. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dr Clifford Douglas Robson North, Gareth Thomas and Namulas Pension Trustees Limited Astrustees of the Northom Limited Retirement Benefit Scheme
    Transactions
    • 07 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 24 avr. 1997
    Livré le 01 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    The plant machnery chattels or other machinery or other equipment set out in the schedule hereto :-negretti & zambra M2236 serial no A442. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 08 nov. 1995
    Livré le 15 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 sept. 2016Commencement of winding up
    19 févr. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin Richard Buttriss
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    practitioner
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    Richard Frank Simms
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    practitioner
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0