NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03104066 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED ?
Adresse du siège social | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 25 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 29 mars 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 25 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Anthony Hunter le 26 nov. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Simon Alton Westrop le 13 janv. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Henry Kennedy Faure Walker le 13 janv. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neil Edward Carpenter le 13 janv. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Anthony Hunter le 13 janv. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP à Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY le 11 déc. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Davidson en tant que directeur le 11 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Henry Kennedy Faure Walker en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER, Neil Edward | Secrétaire | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
WESTROP, Simon Alton | Secrétaire | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
FAURE WALKER, Henry Kennedy | Administrateur | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 187012370001 | ||||
HUNTER, Paul Anthony | Administrateur | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Financial Director | 69320190004 | ||||
GLASS, Josephine Mary | Secrétaire | Cairn Cottage Woodham Park Way Woodham KT15 3SD Addlestone Surrey | British | 44504060001 | ||||||
HUNTER, Paul Anthony | Secrétaire | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
JOSEPH, Anne Janette | Secrétaire | 68 Hillway N6 6DP London | British | Legal Dir | 60285460001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
AIKEN, Iain William | Administrateur | Pendle View, Primrose Hill BB2 7EQ Mellor Lancashire | British | Newspaper Publisher | 83849650001 | |||||
ARMOUR, Mark Henry | Administrateur | 48 Bellamy Street SW12 8BU London | British | Director | 58001830001 | |||||
BROWN, James Thomson | Administrateur | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | Newspaper Chief Executive | 4154210013 | |||||
CHRISTIE, David Gordon | Administrateur | 53 The Mount Fetcham KT22 9EG Leatherhead Surrey | British | Company Director | 75461250001 | |||||
DAVIDSON, Paul | Administrateur | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46356560004 | ||||
JOSEPH, Anne Janette | Administrateur | 68 Hillway N6 6DP London | England | British | Legal Dir | 60285460001 | ||||
MELLON, John Benedict | Administrateur | Westward House 7 Hayes Lane CR8 5LE Kenley Surrey | British | Company Director | 35523050001 | |||||
PFEIL, John Christopher | Administrateur | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | Finance Director | 93412530001 | ||||
RADBURN, Philip Arthur | Administrateur | Pyebirch Manor Eccleshall ST21 6JG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46357310001 | ||||
RADCLIFFE, Willoughby Mark St John | Administrateur | 14 The Orchard Bedford Park W4 1JX London | England | British | Dir Of Corp Services | 32447610001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsquest Media Group Limited | 06 avr. 2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
NEWSQUEST PRINTING (COLCHESTER) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Créé le 05 déc. 1996 Livré le 17 déc. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee and the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 04 janv. 1996 Livré le 19 janv. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargees under the tewrms of each or any of the finance documents in each case together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with it's rights under the finance documents or any other documents securing such liabilities | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0