BORDEN CHEMICAL UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBORDEN CHEMICAL UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03104655
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (20590) / Industries manufacturières

    Où se situe BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INHOCO 436 LIMITED21 sept. 199521 sept. 1995

    Quels sont les derniers comptes de BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Ltd Sully Moors Road Penarth South Glamorgan CF64 5YU à Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB le 08 avr. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 17 mars 2020

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    10 pagesLIQ01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 031046550010 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 031046550011 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 14 nov. 2017

    • Capital: GBP 750,000
    3 pagesSH01

    Nomination de Jean-Paul Aucoin en tant qu'administrateur le 01 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de George Christopher Mackenzie Gallacher en tant que directeur le 01 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    19 pagesAA

    Nomination de Jaap Schilder en tant que secrétaire le 14 déc. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Oliver Healey en tant que secrétaire le 07 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    9 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approval of accounts 01/04/2016
    RES13

    Qui sont les dirigeants de BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCHILDER, Jaap
    3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    Seattleweg 17
    Netherlands
    Secrétaire
    3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    Seattleweg 17
    Netherlands
    220578750001
    AUCOIN, Jean-Paul
    East Broad Street
    Columbus
    180
    Ohio 43215
    United States
    Administrateur
    East Broad Street
    Columbus
    180
    Ohio 43215
    United States
    United StatesCanadianVp & Gm Psr239792590001
    MERTENS, Arnoldus Wilhelmus Maria
    Building 4, 3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    'Port Park' Seattleweg 17
    Netherlands
    Administrateur
    Building 4, 3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    'Port Park' Seattleweg 17
    Netherlands
    NetherlandsDutchInternational Corporate Controller171400070001
    DAVIES, Leighton Wynne
    64 Cornerswell Road
    CF64 2WA Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Secrétaire
    64 Cornerswell Road
    CF64 2WA Penarth
    Vale Of Glamorgan
    BritishFinancial Controller94154900001
    FRAZIER, Peter Stokes
    57 Andes Close
    SO14 3HS Southampton
    Secrétaire
    57 Andes Close
    SO14 3HS Southampton
    AmericanCompany Director49919650001
    GREEN, Anthony
    29 Kenson Gardens
    Sholing
    SO19 8RE Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    29 Kenson Gardens
    Sholing
    SO19 8RE Southampton
    Hampshire
    BritishAccountant803990001
    HEALEY, Richard Oliver
    8 Clos Y Mynydd
    Morganstown
    CF15 8FH Cardiff
    Secrétaire
    8 Clos Y Mynydd
    Morganstown
    CF15 8FH Cardiff
    BritishFinancial Director91123950004
    JONES, Benjamin Harrison
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    Secrétaire
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    British AmericanDirector78219060001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    BEVILAQUA, Joseph Patrick
    3895 Fairlington Drive
    Columbus
    43220
    Ohio
    Administrateur
    3895 Fairlington Drive
    Columbus
    43220
    Ohio
    UsaUnited StatesCompany Director84251820001
    BOKMANS, Cornelis Adrianus
    Windrush Barn
    Police Row, Therfield
    SG8 9QE Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Windrush Barn
    Police Row, Therfield
    SG8 9QE Royston
    Hertfordshire
    DutchCompany Director65565210001
    FRAZIER, Peter Stokes
    2 Wentworth Grange
    SO22 4HZ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    2 Wentworth Grange
    SO22 4HZ Winchester
    Hampshire
    AmericanDirector49919650002
    GALLACHER, George Christopher Mackenzie
    14 Bellister Park
    SR8 1PH Peterlee
    County Durham
    Administrateur
    14 Bellister Park
    SR8 1PH Peterlee
    County Durham
    United KingdomBritishBusiness Manager70971860001
    HARTLAND, Peter John
    8 Ty Westonia
    Chandler's Quay
    CF64 1SL Penarth
    South Glamorgan
    Administrateur
    8 Ty Westonia
    Chandler's Quay
    CF64 1SL Penarth
    South Glamorgan
    BritishBusiness Director76931030002
    JONES, Benjamin Harrison
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    Administrateur
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    British AmericanDirector78219060001
    LANGSTON, James
    Jakarama
    Raridge Lane
    SO32 1DX Bishops Waltham
    Hampshire
    Administrateur
    Jakarama
    Raridge Lane
    SO32 1DX Bishops Waltham
    Hampshire
    EnglandBritishDirector94593180001
    MONTE, Ricardo Marcelo
    Juan Cruz Varela 737
    Acassuso
    Buenos Aires
    1640
    Argentina
    Administrateur
    Juan Cruz Varela 737
    Acassuso
    Buenos Aires
    1640
    Argentina
    AgrentinianVice President47099280002
    SAGGESE, Joseph Michael
    172 Castle Ridge Road
    Manhasset
    New York Ny11030
    Usa
    Administrateur
    172 Castle Ridge Road
    Manhasset
    New York Ny11030
    Usa
    UsaCompany Director17838840001
    VOLKING, Robert Jan
    Oakley House
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Oakley House
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    DutchGp Director Strategic Pla/Busi45659130001
    WHITNEY, Derek Martin
    Lakeside House
    Brighton Road, Sway
    SO41 6EB Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Lakeside House
    Brighton Road, Sway
    SO41 6EB Lymington
    Hampshire
    BritishManaging Director68115770001
    YOUNG, Roger Neville
    Deane Cottage Dean
    Sparsholt
    SO21 2LP Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Deane Cottage Dean
    Sparsholt
    SO21 2LP Winchester
    Hampshire
    BritishConsultant59587740002
    ZAPPALA, Timothy Joseph
    8 Preservation Way
    Westford
    Mass 01886
    Usa
    Administrateur
    8 Preservation Way
    Westford
    Mass 01886
    Usa
    AmericanDirector67618550001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Apollo Global Management Llc
    Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    2711
    United States
    06 avr. 2016
    Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    2711
    United States
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementUsa
    Autorité légaleNew York Stock Exchange Listed
    Lieu d'enregistrementState Of Delaware - Division Of Corporations
    Numéro d'enregistrement4382726
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Borden International Holdings Limited
    Sully Moors Road
    Sully
    CF64 5YU Penarth
    C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Limited
    Wales
    06 avr. 2016
    Sully Moors Road
    Sully
    CF64 5YU Penarth
    C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Limited
    Wales
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Registry
    Numéro d'enregistrement3745631
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BORDEN CHEMICAL UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 sept. 2015
    Livré le 05 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transactions
    • 05 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juil. 2015
    Livré le 12 août 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transactions
    • 12 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security deed
    Créé le 28 mars 2013
    Livré le 10 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any foreign subsidiary loan party to any receiver or any delegate of a receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge the inventory, accounts, collection accounts, licences, other documents see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A. (The "Collateral Agent")
    Transactions
    • 10 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 mai 2005
    Livré le 13 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H hollins vale works croft lane bury t/no GM206532, l/h hollins vale works croft lane t/no GM1717 and GM357591,f/h northwest industrial estate peterlee co durham t/no DU187150. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jp Morgan Chase Bank N.A.
    Transactions
    • 13 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Intellectual property security agreement
    Créé le 31 mai 2005
    Livré le 13 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the chargor's entire right,title and interest now owned or existing and hereafter acquired or arising in the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P.Morgan Europe Limited
    Transactions
    • 13 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 31 mai 2005
    Livré le 07 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a land to the north of davy drive peterlee t/no DU187150 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.a,
    Transactions
    • 07 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 31 mai 2005
    Livré le 07 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a hollins vale works, croft lane, bury, greater manchester t/no GM206532, GM375911, GM1717 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.a,
    Transactions
    • 07 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An amended and restated loan and security agreement
    Créé le 12 août 2004
    Livré le 23 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in all of the following property and interests in property: (I) accounts (ii) certificated securities (iii) chattel paper (iv) computer hardware and software (v) contract rights (vi) deposit accounts. For further details of charges please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fleet National Bank, London Branch as UK Collateral Agent for the U.K. Secured Parties Andfleet Capital Global Finance Inc. as Canadian Collateral Agent for the Canadian Secured Parties
    Transactions
    • 23 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trademark security agreement
    Créé le 12 août 2004
    Livré le 23 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in (I) all trademarks and trademark licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all goodwill (iv) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fleet National Bank, London Branch as UK Collateral Agent for the U.K. Secured Parties Andfleet Capital Global Finance Inc. as Canadian Collateral Agent for the Canadian Secured Parties
    Transactions
    • 23 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Patent security agreement
    Créé le 12 août 2004
    Livré le 23 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in to and under (I) all patents and patents licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fleet National Bank, London Branch as UK Collateral Agent for the U.K. Secured Parties Andfleet Capital Global Finance Inc. as Canadian Collateral Agent for the Canadian Secured Parties
    Transactions
    • 23 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 23 sept. 2002
    Livré le 03 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fleet National Bank (The Security Agent)
    Transactions
    • 03 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BORDEN CHEMICAL UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 mars 2020Commencement of winding up
    13 févr. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony Steven Barrell
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    practitioner
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Gerald Clifford Smith
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    practitioner
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0