BORDEN CHEMICAL UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BORDEN CHEMICAL UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03104655 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?
Adresse du siège social | Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor 170 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Ltd Sully Moors Road Penarth South Glamorgan CF64 5YU à Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB le 08 avr. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 10 pages | LIQ01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 031046550010 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 031046550011 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 9 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 19 pages | AA | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 14 nov. 2017
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Nomination de Jean-Paul Aucoin en tant qu'administrateur le 01 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de George Christopher Mackenzie Gallacher en tant que directeur le 01 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 19 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Jaap Schilder en tant que secrétaire le 14 déc. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Oliver Healey en tant que secrétaire le 07 oct. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHILDER, Jaap | Secrétaire | 3195 Nd Pernis Rotterdam Seattleweg 17 Netherlands | 220578750001 | |||||||
AUCOIN, Jean-Paul | Administrateur | East Broad Street Columbus 180 Ohio 43215 United States | United States | Canadian | Vp & Gm Psr | 239792590001 | ||||
MERTENS, Arnoldus Wilhelmus Maria | Administrateur | Building 4, 3195 Nd Pernis Rotterdam 'Port Park' Seattleweg 17 Netherlands | Netherlands | Dutch | International Corporate Controller | 171400070001 | ||||
DAVIES, Leighton Wynne | Secrétaire | 64 Cornerswell Road CF64 2WA Penarth Vale Of Glamorgan | British | Financial Controller | 94154900001 | |||||
FRAZIER, Peter Stokes | Secrétaire | 57 Andes Close SO14 3HS Southampton | American | Company Director | 49919650001 | |||||
GREEN, Anthony | Secrétaire | 29 Kenson Gardens Sholing SO19 8RE Southampton Hampshire | British | Accountant | 803990001 | |||||
HEALEY, Richard Oliver | Secrétaire | 8 Clos Y Mynydd Morganstown CF15 8FH Cardiff | British | Financial Director | 91123950004 | |||||
JONES, Benjamin Harrison | Secrétaire | 5 Riverview Road W4 3QH Chiswick London | British American | Director | 78219060001 | |||||
A B & C SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
BEVILAQUA, Joseph Patrick | Administrateur | 3895 Fairlington Drive Columbus 43220 Ohio | Usa | United States | Company Director | 84251820001 | ||||
BOKMANS, Cornelis Adrianus | Administrateur | Windrush Barn Police Row, Therfield SG8 9QE Royston Hertfordshire | Dutch | Company Director | 65565210001 | |||||
FRAZIER, Peter Stokes | Administrateur | 2 Wentworth Grange SO22 4HZ Winchester Hampshire | American | Director | 49919650002 | |||||
GALLACHER, George Christopher Mackenzie | Administrateur | 14 Bellister Park SR8 1PH Peterlee County Durham | United Kingdom | British | Business Manager | 70971860001 | ||||
HARTLAND, Peter John | Administrateur | 8 Ty Westonia Chandler's Quay CF64 1SL Penarth South Glamorgan | British | Business Director | 76931030002 | |||||
JONES, Benjamin Harrison | Administrateur | 5 Riverview Road W4 3QH Chiswick London | British American | Director | 78219060001 | |||||
LANGSTON, James | Administrateur | Jakarama Raridge Lane SO32 1DX Bishops Waltham Hampshire | England | British | Director | 94593180001 | ||||
MONTE, Ricardo Marcelo | Administrateur | Juan Cruz Varela 737 Acassuso Buenos Aires 1640 Argentina | Agrentinian | Vice President | 47099280002 | |||||
SAGGESE, Joseph Michael | Administrateur | 172 Castle Ridge Road Manhasset New York Ny11030 Usa | Usa | Company Director | 17838840001 | |||||
VOLKING, Robert Jan | Administrateur | Oakley House Sway Road SO42 7SG Brockenhurst Hampshire | Dutch | Gp Director Strategic Pla/Busi | 45659130001 | |||||
WHITNEY, Derek Martin | Administrateur | Lakeside House Brighton Road, Sway SO41 6EB Lymington Hampshire | British | Managing Director | 68115770001 | |||||
YOUNG, Roger Neville | Administrateur | Deane Cottage Dean Sparsholt SO21 2LP Winchester Hampshire | British | Consultant | 59587740002 | |||||
ZAPPALA, Timothy Joseph | Administrateur | 8 Preservation Way Westford Mass 01886 Usa | American | Director | 67618550001 | |||||
INHOCO FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Management Llc | 06 avr. 2016 | Centerville Road Suite 400 Wilmington 2711 United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Borden International Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Sully Moors Road Sully CF64 5YU Penarth C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Limited Wales | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
BORDEN CHEMICAL UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 28 sept. 2015 Livré le 05 oct. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 27 juil. 2015 Livré le 12 août 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security deed | Créé le 28 mars 2013 Livré le 10 avr. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any foreign subsidiary loan party to any receiver or any delegate of a receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge the inventory, accounts, collection accounts, licences, other documents see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 mai 2005 Livré le 13 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H hollins vale works croft lane bury t/no GM206532, l/h hollins vale works croft lane t/no GM1717 and GM357591,f/h northwest industrial estate peterlee co durham t/no DU187150. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Intellectual property security agreement | Créé le 31 mai 2005 Livré le 13 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of the chargor's entire right,title and interest now owned or existing and hereafter acquired or arising in the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 31 mai 2005 Livré le 07 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The property k/a land to the north of davy drive peterlee t/no DU187150 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 31 mai 2005 Livré le 07 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The property k/a hollins vale works, croft lane, bury, greater manchester t/no GM206532, GM375911, GM1717 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
An amended and restated loan and security agreement | Créé le 12 août 2004 Livré le 23 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in all of the following property and interests in property: (I) accounts (ii) certificated securities (iii) chattel paper (iv) computer hardware and software (v) contract rights (vi) deposit accounts. For further details of charges please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Trademark security agreement | Créé le 12 août 2004 Livré le 23 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in (I) all trademarks and trademark licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all goodwill (iv) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Patent security agreement | Créé le 12 août 2004 Livré le 23 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in to and under (I) all patents and patents licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 23 sept. 2002 Livré le 03 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
BORDEN CHEMICAL UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0