SUPERIOR PRODUCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUPERIOR PRODUCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03107069
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUPERIOR PRODUCE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SUPERIOR PRODUCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUPERIOR PRODUCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GROWERS CHOICE LIMITED05 déc. 199505 déc. 1995
    GREENSENSE LIMITED27 sept. 199527 sept. 1995

    Quels sont les derniers comptes de SUPERIOR PRODUCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SUPERIOR PRODUCE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SUPERIOR PRODUCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 mars 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 sept. 2014

    État du capital au 01 sept. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 sept. 2013

    État du capital au 10 sept. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* le 10 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 mars 2013

    5 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Christopher Thomas en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2012 au 31 mars 2013

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Steve Wood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Gavin Cox le 01 nov. 2011

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Steve Wood le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gavin Cox le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Thomas le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Food Partners House Poyle Road Colnbrook, Slough England SL3 0EN England* le 13 nov. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 01 oct. 2011

    6 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02

    Qui sont les dirigeants de SUPERIOR PRODUCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Secrétaire
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756720001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Secrétaire
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150501100001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    VINCENT, Guy Wyndham
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Secrétaire
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    British70893430002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Secrétaire
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    SECRETAIRE LIMITED
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    Secrétaire désigné
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    900011490001
    BROWN, Kevin Thomas
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Administrateur désigné
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish900008020001
    CHISAMBI, Rodgers Yalamila
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Administrateur
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Zambian77986900001
    FEE, Paul
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    Administrateur
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    British55281590001
    GUY, David Simon
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British119214340001
    HALL, Fraser Scott
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British4578740001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish83660790002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MELLORS, William Peter Stewart
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    British107055640001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    NELSON, Finlay Macarthur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    Administrateur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    EnglandBritish132363820001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Administrateur
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    SINCLAIR, John Frederick
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Administrateur
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British46006710001
    SMITH, Andrew Macdonald
    Chimneys
    Westbury Road
    BR1 2QB Bromley
    Kent
    Administrateur
    Chimneys
    Westbury Road
    BR1 2QB Bromley
    Kent
    British74660050001
    TAYLOR, Agatha
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British58350880001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WEBB, Robert John
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    Administrateur
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    British65669490001
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    WORT, Edward George
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    Administrateur
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    British77987180001

    SUPERIOR PRODUCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 avr. 2008
    Livré le 02 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 02 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture accession deed
    Créé le 16 févr. 2007
    Livré le 05 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)(the Security Agent)
    Transactions
    • 05 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 janv. 2004
    Livré le 10 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 10 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 mars 1999
    Livré le 01 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 déc. 1996
    Livré le 07 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H or l/h property k/a units 187-189 and 190-192A western international market heston l/b of hounslow & all buildings & structures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Superior Foods Limited
    Transactions
    • 07 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 13 déc. 1995
    Livré le 19 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0