SHL (UK) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHL (UK) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03109066
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHL (UK) LTD ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SHL (UK) LTD ?

    Adresse du siège social
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SHL (UK) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SAVILLE & HOLDSWORTH (UK) LIMITED11 déc. 199511 déc. 1995
    STUDIOPRICE LIMITED02 oct. 199502 oct. 1995

    Quels sont les derniers comptes de SHL (UK) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SHL (UK) LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SHL (UK) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 mai 2014

    État du capital au 01 mai 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Catherine Phillips en tant que directeur le 31 juil. 2013

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Catherine Phillips en tant que secrétaire le 31 juil. 2013

    1 pagesTM02

    Nomination de David Edward Ryell en tant qu'administrateur le 31 juil. 2013

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Emma Voirrey Lancaster en tant que directeur le 27 nov. 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Martin David Franks en tant qu'administrateur le 27 nov. 2012

    2 pagesAP01

    Nomination de Catherine Phillips en tant que secrétaire le 01 juin 2012

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Suzanna Barrett en tant que secrétaire le 01 juin 2012

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Suzanna Barrett en tant que directeur le 01 juin 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Catherine Phillips en tant qu'administrateur le 01 juin 2012

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Emma Voirrey Lancaster le 10 févr. 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Suzanna Barrett le 10 févr. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    7 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SHL (UK) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRANKS, Martin David
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish173954290001
    RYELL, David Edward
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish180882130001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    British106880710002
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Secrétaire
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    EVANS, Paul Anthony James
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British38068300001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    170384570001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Secrétaire
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Roger John
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British67674990001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish106880710002
    BURGE, Alan
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    Administrateur
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    United KingdomBritish197259620001
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Administrateur
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    CRAMP, Elisabeth Lyndsay
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    Administrateur
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    EnglandBritish97695420001
    GREGORY, Roger William
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    British59500110001
    HOLDSWORTH, Roger Francis
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    Administrateur
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    British112662000001
    HOWARD, Simon John
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    Administrateur
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    United KingdomBritish73313240006
    LANCASTER, Emma Voirrey
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish79034410005
    MABEY, William
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    British12239710001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish170338110001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SAVILLE, Peter Francis, Dr
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Administrateur
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    British12239700001
    STEVENSON, Hazel Helena
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    Administrateur
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish51232470001
    VAN RAAY, Paul Bernard
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Administrateur
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Dutch90966240001
    VISSER, Gerbrand Joannes Antonius
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Administrateur
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Dutch51232680001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SHL (UK) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 10 janv. 2011
    Livré le 15 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cit Capital Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 15 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    A share pledge agreement
    Créé le 27 mars 2009
    Livré le 06 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due of the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgors have pledged the 12,434 shares no.1 To 12,434 shares inclusive held by shl people solutions group holdings limited and one share no.12,435 Held by the company in shl belgium sa and any other shares in shl belgium that they may subscribe to or acquire in the future see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cit Capital Finance (UK) Limited Acting for Itself and for the Account of the Secured Parties
    Transactions
    • 06 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 mars 2009
    Livré le 06 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cit Capital Finance (UK) Limited as Trustee for Itself and the Other Persons (the Security Trustee)
    Transactions
    • 06 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2007
    Livré le 07 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cit Capital Finance (UK) Limited in Its Capacity Trustee
    Transactions
    • 07 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 19 août 1997
    Livré le 08 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 janv. 1997
    Livré le 22 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0