SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03112420 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | Stonemead House 95 London Road CR0 2RF Croydon Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 02 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées du secrétaire B-Hive Company Secretarial Services Limited le 05 janv. 2026 | 1 pages | CH04 | ||
Cessation de la nomination de David Moorcroft en tant que directeur le 19 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Lois Catherine Forrester le 12 déc. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2025 avec mises à jour | 9 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2024 | 3 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Moorcroft le 26 mars 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 94 Park Lane Croydon Surrey CR0 1JB United Kingdom à Stonemead House 95 London Road Croydon Surrey CR0 2RF le 26 mars 2025 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Howard Malcolm Key le 26 mars 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Nomination de Mr Howard Malcolm Key en tant qu'administrateur le 06 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Mary Elizabeth Fraser en tant que directeur le 06 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023 | 7 pages | AA | ||
Nomination de B-Hive Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 01 juil. 2024 | 2 pages | AP04 | ||
Changement d'adresse du siège social de 23 Swan Hill Shrewsbury SY1 1NN England à 94 Park Lane Croydon Surrey CR0 1JB le 01 oct. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Lois Catherine Forrester le 30 juin 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NN England à 23 Swan Hill Shrewsbury SY1 1NN le 01 juil. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Matthews Block Management Ltd en tant que secrétaire le 30 juin 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2024 avec mises à jour | 8 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Lois Catherine Forrester le 11 avr. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Matthews Block Management Ltd le 20 nov. 2023 | 1 pages | CH04 | ||
Changement d'adresse du siège social de 15 Lower Bridge Street Chester CH1 1RS England à Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NN le 17 oct. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2023 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Jean Lesley Waterman en tant que directeur le 06 avr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de John Christopher Hodnett en tant que directeur le 23 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr John Christopher Hodnett en tant qu'administrateur le 08 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-HIVE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 95 London Road CR0 2RF Croydon Stonemead House Surrey United Kingdom |
| 147749880002 | ||||||||||
| FORRESTER, Lois Catherine | Administrateur | 95 London Road CR0 2RF Croydon Stonemead House England | England | British | 298594670002 | |||||||||
| KEY, Howard Malcolm | Administrateur | 95 London Road CR0 2RF Croydon Stonemead House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 330925150001 | |||||||||
| BARLOW, Frances | Secrétaire | 35 Burlington Place Belle Vue SY3 7LF Shrewsbury Salop | British | 108890330001 | ||||||||||
| BUCKLE, Helen Elizabeth | Secrétaire | 29 Burlington Place SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 93645580001 | ||||||||||
| BURDEKIN, Martin Andrew | Secrétaire | 23 Burlington Place Belle Vue SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 59912540001 | ||||||||||
| ELMES, Diane Elizabeth | Secrétaire | 2 Stones Square SY3 7JA Shrewsbury Salop | British | 121258050001 | ||||||||||
| FRASER, Mary Elizabeth | Secrétaire | 28 Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | 173665920001 | |||||||||||
| GOURLAY, Philip Carl | Secrétaire | 67 Belle Vue Gardens Belle Vue SY3 7JH Shrewsbury Shropshire | British | 40813540001 | ||||||||||
| HARTE, Helen Mary | Secrétaire | 11 Stones Square SY3 7JA Shrewsbury Salop | British | 64678380001 | ||||||||||
| MORIARTY, Jacqueline Ann | Secrétaire | 34 Burlington Place Belle Vue S73 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 54588700001 | ||||||||||
| MATTHEW'S BLOCK MANAGEMENT LTD | Secrétaire | Whitburn Street WV16 4QN Bridgnorth 34 - 35 England | 153030720002 | |||||||||||
| MATTHEWS BLOCK MANAGEMENT LTD | Secrétaire | 11 Queensway BH25 5NN New Milton Queensway House Hampshire England |
| 250269840001 | ||||||||||
| NOCK DEIGHTON (1831) LIMITED | Secrétaire | Whitburn Street WV16 4QN Bridgnorth 34-35 Shropshire |
| 153030720001 | ||||||||||
| ASHLEY, Brian John Albert | Administrateur | St Vincent 3 Hawkstone Court Weston-Under-Redcastle SY4 5XG Shrewsbury Shropshire | British | 32982240002 | ||||||||||
| ASPINALL, Darren John | Administrateur | 3 Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | British | 73304460001 | ||||||||||
| BAGNALL, Jean Isobel | Administrateur | 27 Burlington Place SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 79949870001 | ||||||||||
| BAGNALL, Roger Anthony | Administrateur | 27 Burlington Place SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 79949940001 | ||||||||||
| BARLOW, Frances | Administrateur | Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury 22 Shropshire | United Kingdom | British | 147161220001 | |||||||||
| BONNER, Pamela Joyce | Administrateur | Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury 28 Shropshire England | England | British | 170676890001 | |||||||||
| BROWN, Thomas Mark Escourt | Administrateur | 28 Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 37886740002 | |||||||||
| BUCKLE, Diana Susan | Administrateur | 28 Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 164878760001 | |||||||||
| BUCKLE, Helen Elizabeth | Administrateur | 29 Burlington Place SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 93645580001 | |||||||||
| BURDEKIN, Martin Andrew | Administrateur | 23 Burlington Place Belle Vue SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 59912540001 | ||||||||||
| BYWOOD, Valerie Anne | Administrateur | Lower Bridge Street CH1 1RS Chester 15 England | United Kingdom | British | 220819000001 | |||||||||
| CHILDS, Janet Ann | Administrateur | 28 Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 59331740004 | |||||||||
| DAVIES, Carol | Administrateur | 39 Burlington Place South Hermitage SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 78987860001 | ||||||||||
| DOWNES, Richard | Administrateur | 39 Burlington Place South Hermitage SY3 7LF Shrewsbury Shropshire | British | 78987820001 | ||||||||||
| FRASER, Mary Elizabeth | Administrateur | Park Lane CR0 1JB Croydon 94 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 169418580001 | |||||||||
| GERRARD, Carole | Administrateur | 1 Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | British | 56313390001 | ||||||||||
| GIBBS, Peter | Administrateur | 12 Stones Square SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | British | 56313490002 | ||||||||||
| HARTE, Helen Mary | Administrateur | 11 Stones Square SY3 7JA Shrewsbury Salop | British | 64678380001 | ||||||||||
| HASNIP, Anne Clare | Administrateur | Lower Bridge Street CH1 1RS Chester 15 England | United Kingdom | British | 169452980001 | |||||||||
| HEARN, Helen | Administrateur | 28 Stones Square Belle Vue SY3 7JA Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 155988130001 | |||||||||
| HODNETT, John Christopher | Administrateur | Lower Bridge Street CH1 1RS Chester 15 England | England | British | 299105410001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SOUTH HERMITAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 03 oct. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0