CORDANT MEDICAL SALES LIMITED

CORDANT MEDICAL SALES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCORDANT MEDICAL SALES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03112561
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Activités des agences de travail temporaire (78200) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PREMIERE PERSONNEL SERVICES LIMITED27 déc. 199527 déc. 1995
    ASTRA ROM LIMITED11 oct. 199511 oct. 1995

    Quels sont les derniers comptes de CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Jack Rainer Ullmann en tant que directeur le 12 mars 2021

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 031125610008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 031125610007 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Chris Martin Kenneally en tant que directeur le 16 mars 2020

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 031125610006 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr Alan Connor en tant que secrétaire le 05 mars 2020

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Chris Martin Kenneally en tant qu'administrateur le 05 mars 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Chris Martin Kenneally en tant que directeur le 05 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Connor en tant que secrétaire le 05 mars 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    7 pagesAA

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2016

    7 pagesAAMD

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Modification des détails de Prime Time Recruitment Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mars 2017

    2 pagesPSC05

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Inscription de la charge 031125610008, créée le 15 août 2016

    45 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CONNOR, Alan
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Secrétaire
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    267884130001
    ULLMANN, Phillip Lionel
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritishDirector46458480002
    BELCHEM, Gary
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    Secrétaire
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    British66391670002
    CONNOR, Alan
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Secrétaire
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    BritishDirector118003220001
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Secrétaire
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    British118003050001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Secrétaire
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishCompany Director94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Secrétaire
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishDirector94546740001
    MILLER, David
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    British59650030004
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    Secrétaire
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    77050230003
    BLEASDALE, Kathleen Veronica
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director67650680001
    CARISS, John Stuart
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director69554890001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Administrateur
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishCompany Director86129050001
    DURSTON, Robert
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    Administrateur
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    BritishDirector110017830001
    HALLIDAY, Steven Don
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director61413670001
    KENNEALLY, Chris Martin
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    WalesBritishCompany Director267876240001
    KENNEALLY, Chris Martin
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    WalesBritishDirector267876240001
    KIRKPATRICK, Steven William
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Northern IrelandNorthern IrishDirector185295780002
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Administrateur
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishCompany Director94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Administrateur
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishDirector94546740001
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Administrateur
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    IrishCompany Director78893160002
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Administrateur
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    IrishDirector78893160002
    PERCIVAL, Lorraine Elizabeth
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector85413680001
    PILGRIM, Alan John Templer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Executive11755290002
    PINDER, John Richard
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    BritishFinance Director78379030001
    ULLMANN, Jack Rainer
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritishDirector11342820001
    ULLMANN, Marianne Flora
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    Cheron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritishDirector6228260001
    WILLIAMSON, Mark
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    Administrateur
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    BritishDirector64862020001
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Administrateur désigné
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001
    WACKS CALLER LIMITED
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    Administrateur
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    58396030003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cordant People Limited
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    06 avr. 2016
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish
    Lieu d'enregistrementUk Companies House
    Numéro d'enregistrement02636670
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CORDANT MEDICAL SALES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 août 2016
    Livré le 15 août 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Centrovalli LTD
    Transactions
    • 15 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 sept. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 12 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 2 of the debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 12 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 sept. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 12 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 07 janv. 2000
    Livré le 26 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transactions
    • 26 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 août 1999
    Livré le 25 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 25 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 août 1998
    Livré le 12 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 22 déc. 1997
    Livré le 09 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 mai 1996
    Livré le 29 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0