CORDANT MEDICAL SALES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CORDANT MEDICAL SALES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03112561 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?
Adresse du siège social | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Cessation de la nomination de Jack Rainer Ullmann en tant que directeur le 12 mars 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Satisfaction de la charge 031125610008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 031125610007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Cessation de la nomination de Chris Martin Kenneally en tant que directeur le 16 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Satisfaction de la charge 031125610006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Nomination de Mr Alan Connor en tant que secrétaire le 05 mars 2020 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Chris Martin Kenneally en tant qu'administrateur le 05 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Chris Martin Kenneally en tant que directeur le 05 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alan Connor en tant que secrétaire le 05 mars 2020 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 7 pages | AA | ||
Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2016 | 7 pages | AAMD | ||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||
Modification des détails de Prime Time Recruitment Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mars 2017 | 2 pages | PSC05 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 031125610008, créée le 15 août 2016 | 45 pages | MR01 | ||
Qui sont les dirigeants de CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNOR, Alan | Secrétaire | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | 267884130001 | |||||||
ULLMANN, Phillip Lionel | Administrateur | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | England | British | Director | 46458480002 | ||||
BELCHEM, Gary | Secrétaire | 17 Turkey Oak Close Upper Norwood SE19 2NZ London | British | 66391670002 | ||||||
CONNOR, Alan | Secrétaire | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | British | Director | 118003220001 | |||||
GARRATT, Mark Jonathan | Secrétaire | 21 Stradella Road Herne Hill SE24 9HN London | British | 118003050001 | ||||||
MARKS, Dorian Alan | Secrétaire | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Company Director | 94546740001 | |||||
MARKS, Dorian Alan | Secrétaire | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Director | 94546740001 | |||||
MILLER, David | Secrétaire | 3 Worsdell Way SG4 0EB Hitchin Hertfordshire | British | 59650030004 | ||||||
TAYLOR, Michael John | Secrétaire | 6 Garratts Lane SM7 2DZ Banstead Surrey | British | 64380001 | ||||||
FNCS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 16 Churchill Way CF1 4DX Cardiff | 900011830001 | |||||||
WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED | Secrétaire | Wacks Caller Steam Packet House 76 Cross Street M2 4JU Manchester | 77050230003 | |||||||
BLEASDALE, Kathleen Veronica | Administrateur | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 67650680001 | ||||
CARISS, John Stuart | Administrateur | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 69554890001 | ||||
CHAPMAN, Clive Richard | Administrateur | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | United Kingdom | British | Company Director | 86129050001 | ||||
DURSTON, Robert | Administrateur | 13 Roundell Road BB18 6EB Barnoldswick Lancashire | British | Director | 110017830001 | |||||
HALLIDAY, Steven Don | Administrateur | Laneside Wallbank Road Bramhall SK7 3AP Stockport Cheshire | England | British | Company Director | 61413670001 | ||||
KENNEALLY, Chris Martin | Administrateur | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | Wales | British | Company Director | 267876240001 | ||||
KENNEALLY, Chris Martin | Administrateur | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | Wales | British | Director | 267876240001 | ||||
KIRKPATRICK, Steven William | Administrateur | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 185295780002 | ||||
MARKS, Dorian Alan | Administrateur | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Company Director | 94546740001 | |||||
MARKS, Dorian Alan | Administrateur | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Director | 94546740001 | |||||
O'BRIEN, Fergal | Administrateur | 79 Hermitage Road WA15 8BW Hale Cheshire | Irish | Company Director | 78893160002 | |||||
O'BRIEN, Fergal | Administrateur | 79 Hermitage Road WA15 8BW Hale Cheshire | Irish | Director | 78893160002 | |||||
PERCIVAL, Lorraine Elizabeth | Administrateur | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | United Kingdom | British | Director | 85413680001 | ||||
PILGRIM, Alan John Templer | Administrateur | 44 Pepper Hill Great Amwell SG12 9RZ Ware Hertfordshire | England | British | Chief Executive | 11755290002 | ||||
PINDER, John Richard | Administrateur | West Pelham Manor Park BR7 5QE Chislehurst Kent | British | Finance Director | 78379030001 | |||||
ULLMANN, Jack Rainer | Administrateur | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | England | British | Director | 11342820001 | ||||
ULLMANN, Marianne Flora | Administrateur | Cheron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | England | British | Director | 6228260001 | ||||
WILLIAMSON, Mark | Administrateur | 94 Ringley Road Whitefield M45 7UV Manchester | British | Director | 64862020001 | |||||
FNCS LIMITED | Administrateur désigné | 16 Churchill Way CF1 4DX Cardiff | 900011820001 | |||||||
WACKS CALLER LIMITED | Administrateur | Wacks Caller Steam Packet House 76 Cross Street M2 4JU Manchester | 58396030003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CORDANT MEDICAL SALES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordant People Limited | 06 avr. 2016 | Long Lane Hillingdon UB10 9PF Uxbridge Chevron House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CORDANT MEDICAL SALES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 15 août 2016 Livré le 15 août 2016 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 04 juin 2015 Livré le 12 juin 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 2 of the debenture. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 04 juin 2015 Livré le 12 juin 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the debenture. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 07 janv. 2000 Livré le 26 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 18 août 1999 Livré le 25 août 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 août 1998 Livré le 12 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 22 déc. 1997 Livré le 09 janv. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 20 mai 1996 Livré le 29 mai 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0