GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED

GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03114400
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHAREHOLDER COMMUNICATIONS PLC20 févr. 199820 févr. 1998
    SHAREHOLDER COMMUNICATIONS CORPORATION (UK) PLC16 oct. 199516 oct. 1995

    Quels sont les derniers comptes de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 29 avr. 2014

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Mr Christopher Andrew Mills en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    9 pagesMG02

    legacy

    7 pagesMG02

    legacy

    7 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Jonathan Dolbear en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    15 pagesAA

    Nomination de Nazir Sarkar en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher Morris en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de James Hood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    15 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield le 15 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Secrétaire
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    South African105560560001
    DOLBEAR, Jonathan
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    Secrétaire
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    161908810001
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Administrateur
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    United KingdomSouth African105560560001
    MILLS, Christopher Andrew
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    Administrateur
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    EnglandBritish178211930001
    OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    Administrateur
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    EnglandBritish116701010001
    SARKAR, Nazir
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    Administrateur
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    United KingdomBritish157131040003
    COE, Lorraine Elizabeth
    3 St Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    3 St Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    British24485080001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Secrétaire
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    British83564940010
    DEVON, David John
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    Secrétaire
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    British7756250002
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    British60270470001
    GREENHALGH, John William
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    Secrétaire
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    British15630560001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    British53858740001
    BAILES, David Delisle
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Administrateur
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    South African92919610001
    BORONKAY, Ronald
    17 State Street
    NY 1000Y New York
    Usa
    Administrateur
    17 State Street
    NY 1000Y New York
    Usa
    Us Citizen62203530002
    CHANDOHA, Walter Sam
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Administrateur
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    American62029490001
    CHAPMAN, Robert William Frederick
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish110216200001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritish83564940010
    CROSBY, William Stuart
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Administrateur
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Australian108743530001
    DEVON, David John
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    Administrateur
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    British7756250001
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    UkBritish60270470001
    GREENHALGH, John William
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    Administrateur
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    United KingdomBritish15630560001
    HOOD, James Terence
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    Administrateur
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritish189833420001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    British53858740001
    MARSHALL, Timothy Thomas
    9 Trentishoe Mansions
    90 Charing Cross Road
    WC2H 0JE London
    Administrateur
    9 Trentishoe Mansions
    90 Charing Cross Road
    WC2H 0JE London
    American87963030001
    MILLER, Alexander
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Administrateur
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Us Citizen57588460002
    MORRIS, Christopher John
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Administrateur
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    AustraliaAustralian114812600001
    PALMER, Samantha
    17 Athelstan Road
    ME4 6EJ Chatham
    Kent
    Administrateur
    17 Athelstan Road
    ME4 6EJ Chatham
    Kent
    British52210680002
    SMITH, Jason Leigh
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Administrateur
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Australian115310950001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish113777700001

    GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Pledge agreement
    Créé le 22 sept. 2003
    Livré le 03 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Provident Bank
    Transactions
    • 03 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 sept. 2003
    Livré le 26 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Provident Bank (The "Agent")
    Transactions
    • 26 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 16 juin 1998
    Livré le 25 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the guarantee or the credit agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Provident Bank
    Transactions
    • 25 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0