GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03114400 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 29 avr. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2013 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Andrew Mills en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2012 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 9 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 7 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 7 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2011 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jonathan Dolbear en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2010 | 15 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Nazir Sarkar en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Morris en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Hood en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield le 15 avr. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Secrétaire | Penthouse A, Spring Leigh Church Road, Leigh Woods BS8 3PG Bristol North Somerset | South African | 105560560001 | ||||||
| DOLBEAR, Jonathan | Secrétaire | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | 161908810001 | |||||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Administrateur | Penthouse A, Spring Leigh Church Road, Leigh Woods BS8 3PG Bristol North Somerset | United Kingdom | South African | 105560560001 | |||||
| MILLS, Christopher Andrew | Administrateur | Park Lane, Blagdon BS40 7SB Bristol Heronmere England | England | British | 178211930001 | |||||
| OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert | Administrateur | Holt Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill BS40 8QR Chew Magna Greenleigh Farm Bristol England | England | British | 116701010001 | |||||
| SARKAR, Nazir | Administrateur | Pier Road Portishead BS20 7DZ Bristol Whitehaven | United Kingdom | British | 157131040003 | |||||
| COE, Lorraine Elizabeth | Secrétaire | 3 St Albans Road IG8 9EQ Woodford Green Essex | British | 24485080001 | ||||||
| CORNEY, Darryl John | Secrétaire | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | 83564940010 | ||||||
| DEVON, David John | Secrétaire | Lynwood Camden Road DA5 3NP Bexley Kent | British | 7756250002 | ||||||
| DUDLEY, Michael Charles | Secrétaire | High Timber Chislehurst Road BR7 5LD Chislehurst Kent | British | 60270470001 | ||||||
| GREENHALGH, John William | Secrétaire | 5 Coutts Crescent NW5 1RF London | British | 15630560001 | ||||||
| HOPKINSON, Ian Michael | Secrétaire | 10 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | 53858740001 | ||||||
| BAILES, David Delisle | Administrateur | Flat C 66 Elm Park Road SW3 6AU London | South African | 92919610001 | ||||||
| BORONKAY, Ronald | Administrateur | 17 State Street NY 1000Y New York Usa | Us Citizen | 62203530002 | ||||||
| CHANDOHA, Walter Sam | Administrateur | 333 East 79th Street Apt Phn New York Ny 10021 Usa | American | 62029490001 | ||||||
| CHAPMAN, Robert William Frederick | Administrateur | Lough Beltra 76 Lymington Bottom, Four Marks GU34 5AH Alton Hampshire | United Kingdom | British | 110216200001 | |||||
| CORNEY, Darryl John | Administrateur | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British | 83564940010 | |||||
| CROSBY, William Stuart | Administrateur | 705 Tead Froad Shad Thames SE1 2AS London | Australian | 108743530001 | ||||||
| DEVON, David John | Administrateur | 25 New Street Square EC4A 3LN London | British | 7756250001 | ||||||
| DUDLEY, Michael Charles | Administrateur | High Timber Chislehurst Road BR7 5LD Chislehurst Kent | Uk | British | 60270470001 | |||||
| GREENHALGH, John William | Administrateur | 5 Coutts Crescent NW5 1RF London | United Kingdom | British | 15630560001 | |||||
| HOOD, James Terence | Administrateur | Redland Road BS6 6YA Bristol 140b Avon United Kingdom | England | British | 189833420001 | |||||
| HOPKINSON, Ian Michael | Administrateur | 10 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | 53858740001 | ||||||
| MARSHALL, Timothy Thomas | Administrateur | 9 Trentishoe Mansions 90 Charing Cross Road WC2H 0JE London | American | 87963030001 | ||||||
| MILLER, Alexander | Administrateur | 17 State Street New York Ny 1000y | Us Citizen | 57588460002 | ||||||
| MORRIS, Christopher John | Administrateur | 608 Spice Quay Heights 32 Shad Thames SE1 2YL London | Australia | Australian | 114812600001 | |||||
| PALMER, Samantha | Administrateur | 17 Athelstan Road ME4 6EJ Chatham Kent | British | 52210680002 | ||||||
| SMITH, Jason Leigh | Administrateur | 2 Providence Lane Long Ashton BS41 9DG Bristol | Australian | 115310950001 | ||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Administrateur | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | England | British | 113777700001 |
GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Pledge agreement | Créé le 22 sept. 2003 Livré le 03 oct. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 sept. 2003 Livré le 26 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 juin 1998 Livré le 25 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the guarantee or the credit agreement of even date | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0