CHUBB LONDON GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHUBB LONDON GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03115073
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ACE LONDON GROUP LIMITED14 juil. 199814 juil. 1998
    ACE UK LIMITED20 nov. 199520 nov. 1995
    3046TH SINGLE MEMBER SHELF TRADING COMPANY LIMITED19 oct. 199519 oct. 1995

    Quels sont les derniers comptes de CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2022

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD à 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 11 mai 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    16 pagesLIQ10

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2021

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2020

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2019

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP United Kingdom à Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD le 22 oct. 2018

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP

    2 pagesAD02

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 sept. 2018

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2016

    État du capital au 16 juin 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ace London Services Limited le 30 mars 2016

    1 pagesCH04

    Statuts

    25 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed ace london group LIMITED\certificate issued on 30/03/16
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name30 mars 2016

    Changement de nom" par disposition dans les statuts

    NM04

    Changement d'adresse du siège social de Ace Building 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP à 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP le 25 févr. 2016

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ace London Services Limited le 24 févr. 2016

    1 pagesCH04

    Nomination de Ashley Craig Mullins en tant qu'administrateur le 05 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHUBB LONDON SERVICES LIMITED
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Secrétaire
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03115073
    73849550003
    HAMMOND, Mark Kent
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Administrateur
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomAmerican174190760002
    KENDRICK, Andrew James
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Administrateur
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomBritish62276900004
    MULLINS, Ashley Craig
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    EnglandAustralian205193200001
    BROWN, Alexander Johnston
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    Secrétaire
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    British2569760001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secrétaire
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    CHARMAN, John Robert
    Dell House Wilderness Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Dell House Wilderness Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    British14016810001
    CIGELNIK, Randi Lyn
    28 Pilgrims Lane
    NW3 1SN London
    Administrateur
    28 Pilgrims Lane
    NW3 1SN London
    American88380810001
    CURTIS, Philippa Mary
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    Administrateur
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    United KingdomBritish40995560001
    CURTIS, Philippa Mary
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    Administrateur
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    United KingdomBritish40995560001
    DUPERREAULT, Brian
    Paget Hall
    15 Harbour Road
    Paget Pg02
    Bermuda
    Administrateur
    Paget Hall
    15 Harbour Road
    Paget Pg02
    Bermuda
    American75259420003
    DUPERREAULT, Brian
    Sanctuary
    55 Harbour Road
    PG02 Paget
    Bermuda
    Administrateur
    Sanctuary
    55 Harbour Road
    PG02 Paget
    Bermuda
    BermudaU.S. Citizen75259420002
    FIELD, Roger Anthony
    South View
    The Green
    TN11 8QR Leigh
    Kent
    Administrateur
    South View
    The Green
    TN11 8QR Leigh
    Kent
    EnglandBritish101275950001
    FREDERICO, Dominic J
    4 Windy Hollow Road
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    United States
    Administrateur
    4 Windy Hollow Road
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    United States
    American75112830001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Administrateur
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GOODMAN, Leslie David
    19 Tideswell Road
    Putney
    SW15 6LJ London
    Administrateur
    19 Tideswell Road
    Putney
    SW15 6LJ London
    EnglandBritish7683930001
    HAMPTON, Clifford Samuel Herbert
    Marshgate House
    36 Sheen Road
    TW9 1AW Richmond
    Surrey
    Administrateur
    Marshgate House
    36 Sheen Road
    TW9 1AW Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish36483720001
    KENDRICK, Andrew James
    23 Klea Avenue
    SW4 9HG London
    Administrateur
    23 Klea Avenue
    SW4 9HG London
    United KingdomBritish62276900003
    KRAMER, Donald
    1 Beekman Place
    New York 10022
    Usa
    Administrateur
    1 Beekman Place
    New York 10022
    Usa
    Us50057850001
    LANGE, Michael Clemens Anton
    1 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    Administrateur
    1 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    American48641670001
    LLOYD, Jeffrey John
    5 Scotia Building
    Jardine Road
    E1 9WA London
    Administrateur
    5 Scotia Building
    Jardine Road
    E1 9WA London
    British45902540002
    LOSCHERT, William James
    Flat 1
    45 Cadogan Square
    SW1X 0HX London
    Administrateur
    Flat 1
    45 Cadogan Square
    SW1X 0HX London
    United KingdomAmerican51396620001
    POOLE, David Charles, The Lord
    19 Keyes Road
    NW2 3XB London
    Administrateur
    19 Keyes Road
    NW2 3XB London
    United KingdomBritish84127430001
    SCHMALZRIEDT, Gary
    188 East 76th Street
    Penthouse A
    New York 1002
    United States
    Administrateur
    188 East 76th Street
    Penthouse A
    New York 1002
    United States
    American76185280007
    SMITH, Michael Gordon
    9 Fournier Street
    E1 6QE London
    Administrateur
    9 Fournier Street
    E1 6QE London
    British58386920001
    UNDERHILL, Kenneth Landers Hoffman
    Ace Building
    100 Leadenhall Street London
    EC3A 3BP
    Administrateur
    Ace Building
    100 Leadenhall Street London
    EC3A 3BP
    EnglandBritish132498240001
    WILLIAMS, Graham David
    18 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    18 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    British6283470002
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Administrateur désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001760001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03600577
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CHUBB LONDON GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 28 janv. 2010
    Livré le 03 févr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re ace london group limited. Clients premium account. Account number 90535192.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deposit trust deed (third party)(the "trust deed")
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 12 nov. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of the company incurred by the company as an underwriting member of the society at any time before the termination date 9BEING the 80TH anniversary of the date of the trust deed) including obligations to the society and the trustees (as defined)
    Brèves mentions
    All such moneys/other property approved by the council of lloyd's as have been paid or transferred by the depositor or trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871 by the Name of Lloyd's,as Trustees
    Transactions
    • 12 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 27 nov. 1996
    Livré le 09 déc. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over the deposit being all money in any currency deposited with the bank pursuant to the deposit being:- barclays bank PLC re ace UK limited treasurers sterling bid deposit no 42727855. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 26 nov. 1996
    Livré le 11 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over deposit
    Créé le 27 mars 1996
    Livré le 05 avr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the deed of counter indemnity and/or the guarantee (both as therein defined)
    Brèves mentions
    All monies at any time standing to the credit of the account of the company in the books of bank of scotland treasury services PLC together with all interest and other amount accruing on such sums.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)

    CHUBB LONDON GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 sept. 2018Commencement of winding up
    17 mars 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Neil John Mather
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0