CHUBB LONDON GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CHUBB LONDON GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03115073 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | 30 Old Bailey EC4M 7AU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2022 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD à 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 11 mai 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal | 16 pages | LIQ10 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2021 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2020 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 sept. 2019 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP United Kingdom à Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD le 22 oct. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ace London Services Limited le 30 mars 2016 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Statuts | 25 pages | MA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed ace london group LIMITED\certificate issued on 30/03/16 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ace Building 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP à 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP le 25 févr. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ace London Services Limited le 24 févr. 2016 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Nomination de Ashley Craig Mullins en tant qu'administrateur le 05 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUBB LONDON SERVICES LIMITED | Secrétaire | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom |
| 73849550003 | ||||||||||
| HAMMOND, Mark Kent | Administrateur | Old Bailey EC4M 7AU London 30 | United Kingdom | American | 174190760002 | |||||||||
| KENDRICK, Andrew James | Administrateur | Old Bailey EC4M 7AU London 30 | United Kingdom | British | 62276900004 | |||||||||
| MULLINS, Ashley Craig | Administrateur | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | England | Australian | 205193200001 | |||||||||
| BROWN, Alexander Johnston | Secrétaire | 4 The Grangeway Grange Park N21 2HA London | British | 2569760001 | ||||||||||
| GLOVER, Michael Logan | Secrétaire | Dunelm 41. St. Catherines Road EN10 7LD Broxbourne Herts | British | 94249710001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Secrétaire désigné | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| CHARMAN, John Robert | Administrateur | Dell House Wilderness Avenue TN15 0EA Sevenoaks Kent | British | 14016810001 | ||||||||||
| CIGELNIK, Randi Lyn | Administrateur | 28 Pilgrims Lane NW3 1SN London | American | 88380810001 | ||||||||||
| CURTIS, Philippa Mary | Administrateur | Flat 20 St Hilda's Wharf 160 Wapping High Street E1W 3PG London | United Kingdom | British | 40995560001 | |||||||||
| CURTIS, Philippa Mary | Administrateur | Flat 20 St Hilda's Wharf 160 Wapping High Street E1W 3PG London | United Kingdom | British | 40995560001 | |||||||||
| DUPERREAULT, Brian | Administrateur | Paget Hall 15 Harbour Road Paget Pg02 Bermuda | American | 75259420003 | ||||||||||
| DUPERREAULT, Brian | Administrateur | Sanctuary 55 Harbour Road PG02 Paget Bermuda | Bermuda | U.S. Citizen | 75259420002 | |||||||||
| FIELD, Roger Anthony | Administrateur | South View The Green TN11 8QR Leigh Kent | England | British | 101275950001 | |||||||||
| FREDERICO, Dominic J | Administrateur | 4 Windy Hollow Road New Hope Pennsylvania 18938 United States | American | 75112830001 | ||||||||||
| GLOVER, Michael Logan | Administrateur | Dunelm 41. St. Catherines Road EN10 7LD Broxbourne Herts | British | 94249710001 | ||||||||||
| GOODMAN, Leslie David | Administrateur | 19 Tideswell Road Putney SW15 6LJ London | England | British | 7683930001 | |||||||||
| HAMPTON, Clifford Samuel Herbert | Administrateur | Marshgate House 36 Sheen Road TW9 1AW Richmond Surrey | United Kingdom | British | 36483720001 | |||||||||
| KENDRICK, Andrew James | Administrateur | 23 Klea Avenue SW4 9HG London | United Kingdom | British | 62276900003 | |||||||||
| KRAMER, Donald | Administrateur | 1 Beekman Place New York 10022 Usa | Us | 50057850001 | ||||||||||
| LANGE, Michael Clemens Anton | Administrateur | 1 Queens Elm Square SW3 6ED London | American | 48641670001 | ||||||||||
| LLOYD, Jeffrey John | Administrateur | 5 Scotia Building Jardine Road E1 9WA London | British | 45902540002 | ||||||||||
| LOSCHERT, William James | Administrateur | Flat 1 45 Cadogan Square SW1X 0HX London | United Kingdom | American | 51396620001 | |||||||||
| POOLE, David Charles, The Lord | Administrateur | 19 Keyes Road NW2 3XB London | United Kingdom | British | 84127430001 | |||||||||
| SCHMALZRIEDT, Gary | Administrateur | 188 East 76th Street Penthouse A New York 1002 United States | American | 76185280007 | ||||||||||
| SMITH, Michael Gordon | Administrateur | 9 Fournier Street E1 6QE London | British | 58386920001 | ||||||||||
| UNDERHILL, Kenneth Landers Hoffman | Administrateur | Ace Building 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP | England | British | 132498240001 | |||||||||
| WILLIAMS, Graham David | Administrateur | 18 Ince Road Burwood Park KT12 5BJ Walton On Thames Surrey | British | 6283470002 | ||||||||||
| LOVITING LIMITED | Administrateur désigné | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001760001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHUBB LONDON GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Market Company Limited | 06 avr. 2016 | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CHUBB LONDON GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge over credit balances | Créé le 28 janv. 2010 Livré le 03 févr. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re ace london group limited. Clients premium account. Account number 90535192. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit trust deed (third party)(the "trust deed") | Créé le 22 oct. 1997 Livré le 12 nov. 1997 | En cours | Montant garanti All the underwriting obligations of the company incurred by the company as an underwriting member of the society at any time before the termination date 9BEING the 80TH anniversary of the date of the trust deed) including obligations to the society and the trustees (as defined) | |
Brèves mentions All such moneys/other property approved by the council of lloyd's as have been paid or transferred by the depositor or trustees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 27 nov. 1996 Livré le 09 déc. 1996 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over the deposit being all money in any currency deposited with the bank pursuant to the deposit being:- barclays bank PLC re ace UK limited treasurers sterling bid deposit no 42727855. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Créé le 26 nov. 1996 Livré le 11 déc. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over deposit | Créé le 27 mars 1996 Livré le 05 avr. 1996 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the deed of counter indemnity and/or the guarantee (both as therein defined) | |
Brèves mentions All monies at any time standing to the credit of the account of the company in the books of bank of scotland treasury services PLC together with all interest and other amount accruing on such sums. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CHUBB LONDON GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0