ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC

ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03117355
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ?

    Adresse du siège social
    199 Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RCM TECHNOLOGY TRUST PLC30 avr. 200730 avr. 2007
    FINSBURY TECHNOLOGY TRUST PLC18 oct. 199518 oct. 1995

    Quels sont les derniers comptes de ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 nov. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 nov. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 nov. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,278,721.750625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 mars 2025Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRITE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS REPURCHASED

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,268,349.675625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 mars 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,264,599.675625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    12 févr. 2025Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEVICE THAT APPROPRITE DUTY BEEN PAID ON THIS REPURCHASED.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,260,849.675625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    04 févr. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,254,940.425625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 janv. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,250,092.300625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    22 janv. 2025Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,246,967.300625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 janv. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,237,592.300625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    06 janv. 2025Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Nomination de Ms Lucy Costa Duarte en tant qu'administrateur le 01 janv. 2025

    2 pagesAP01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,228,842.300625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 déc. 2024Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRITE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS REPURCHSED

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,226,947.275625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 déc. 2024Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,221,947.275625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    18 nov. 2024Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,212,572.275625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    11 nov. 2024Clarification HMRC CONFIRMATION received that appropriate duty that has been paid on this repurchased.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,197,572.275625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    08 nov. 2024Clarification HMRC CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRITE DUTY HAS BEEN PAID ON THIS REPURCHASED

    Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,187,572.275625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 oct. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,183,822.275625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 juil. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,169,077.400625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    01 juil. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,179,077.400625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    01 juil. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,144,077.400625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    29 mai 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,132,463.950625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 mai 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    82 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,128,713.950625
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 mai 2024Clarification HMRC confirmation duty paid

    Statuts

    79 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Enter into agreement that would require relevant securities 24/04/2024
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NICE, Kelly
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    297449270001
    SALT, Kirsten June
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    England
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    England
    British38993290004
    DAVIS, Simon Lee
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    EnglandBritishInvestment Manager112707380002
    DUARTE, Lucy Costa
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    EnglandBritishNon-Executive Director330838890001
    PATEL, Neeta
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    EnglandBritishDirector262119690001
    SCHOLEFIELD, Timothy
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    United KingdomBritishDirector 193535210001
    SCOTT, Elisabeth Charlotte
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    EnglandBritishCompany Director158482270001
    THOMSON, Ekaterina
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    United KingdomBritishCompany Director160591270001
    EMUSS, Eleanor
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    235121360001
    INGRAM, Peter William Irving
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    England
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    England
    British169956460001
    LAGO, Tracey Anne
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    195460410001
    CLOSE FINSBURY ASSET MANAGEMENT LIMITED
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    Secrétaire
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    70688480002
    CLOSE INVESTMENTS LIMITED
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    Secrétaire
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    117475800001
    FINSBURY ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Alderman's House Alderman's Walk
    EC2M 3XR London
    Secrétaire
    Alderman's House Alderman's Walk
    EC2M 3XR London
    45405000001
    LEGIST SECRETARIES LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Secrétaire désigné
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    900006080001
    REA BROTHERS LIMITED
    Aldermans House Aldermans Walk
    EC2M 3XR London
    Secrétaire
    Aldermans House Aldermans Walk
    EC2M 3XR London
    26633510001
    CORNISH, John Essex
    Oakwood Quarry Road
    RH8 9HF Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Oakwood Quarry Road
    RH8 9HF Oxted
    Surrey
    UkBritishNon Exec Director12118250001
    GAUNT, Paul
    Cornfield Road
    Mulbarton
    NR14 8GQ Norwich
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Cornfield Road
    Mulbarton
    NR14 8GQ Norwich
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director45788750005
    HOARE, Richard Quintin
    Tangier House
    Wootton St Lawrence
    RG23 8PH Basingstoke
    Hants
    Administrateur
    Tangier House
    Wootton St Lawrence
    RG23 8PH Basingstoke
    Hants
    UkBritishBanker13534770001
    HOLWAY, Richard William
    4 Swifts Close
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QX Farnham
    Surrey
    Administrateur
    4 Swifts Close
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QX Farnham
    Surrey
    EnglandBritishTechnology Analyst17878010002
    JEENS, Robert Charles Hubert
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    England
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant33252290005
    LENYGON, Bryan Norman
    Highfield
    Bells Yew Green
    TN3 9AP Tonbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Highfield
    Bells Yew Green
    TN3 9AP Tonbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant7219320001
    MARTIN, Christopher John, Dr
    Inwood
    New Road
    PO33 4HY Wootton Bridge
    Isle Of Wight
    Administrateur
    Inwood
    New Road
    PO33 4HY Wootton Bridge
    Isle Of Wight
    United KingdomBritishDir Ceo37607120001
    POTTER, David Edwin, Dr
    8 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UG London
    Administrateur
    8 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UG London
    United KingdomBritishCompany Director3023030001
    QUYSNER, David William
    The Old Vicarage
    Selmeston
    BN26 6TY Polegate
    East Sussex
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Selmeston
    BN26 6TY Polegate
    East Sussex
    United KingdomBritishInvestment Manager142413220001
    TOWNSEND, John Anthony Victor
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritishDirector97263430005
    VAN DER KLUGT, Humphrey
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TY London
    199
    EnglandBritishDirector109117640002
    LEGIST DIRECTORS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Administrateur désigné
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    900006070001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0