KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED

KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKRUPACO FINANCE (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03123030
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED ?

    • Autre octroi de crédit n.c.a. (64929) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o TAYLOR WESSING LLP
    5 New Street Square
    EC4A 3TW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOGANPARK LIMITED07 nov. 199507 nov. 1995

    Quels sont les derniers comptes de KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de solvabilité

    7 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 déc. 2014

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 nov. 2014

    État du capital au 07 nov. 2014

    • Capital: USD 10,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    16 pagesAA

    Nomination de Mr. David Angel en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Arthur Custance en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 nov. 2013

    État du capital au 06 nov. 2013

    • Capital: USD 10,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    16 pagesAA

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 27 déc. 2012

    • Capital: USD 10,000
    4 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Sean Clancy en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Janet Shulist en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    17 pagesAA

    legacy

    2 pagesSH20

    Qui sont les dirigeants de KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHULIST, Janet
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    Secrétaire
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    164777480001
    ANGEL, David, Mr.
    c/o Kruger Inc.
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    Administrateur
    c/o Kruger Inc.
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    CanadaCanadian188887190001
    BUNZE, George John
    238 St Raphael
    Ile Bizard Montreal
    FOREIGN Quebec
    H9e 1sz
    Administrateur
    238 St Raphael
    Ile Bizard Montreal
    FOREIGN Quebec
    H9e 1sz
    CanadaCanadian34173550002
    GELBER, David
    6 Clorane Gardens
    NW3 7IR London
    Administrateur
    6 Clorane Gardens
    NW3 7IR London
    United KingdomCanadian9565460001
    KRUGER II, Joseph
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    CanadaCanadian32125150003
    CLANCY, Sean Aidan
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    British36561400004
    SCOTT, Andrew Munro
    106 Aylmer Road
    W12 9LQ London
    Secrétaire
    106 Aylmer Road
    W12 9LQ London
    British67475550002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CUSTANCE, Arthur Brian
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    CanadaCanadian48513480007
    GRAHAM, Kenneth
    30 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    Administrateur
    30 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    British48815960003
    HUEY EVANS, Gay
    9 Eaton Mansions
    Cliveden Place
    SW1W 8HE London
    Administrateur
    9 Eaton Mansions
    Cliveden Place
    SW1W 8HE London
    United KingdomAmerican81476710001
    JANSSEN, Claude
    7 Avenue Emile Acollas
    75007 Paris
    France
    Administrateur
    7 Avenue Emile Acollas
    75007 Paris
    France
    French48837570001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STURGEON, Colin Lindsay
    44 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY Chelsea
    London
    Administrateur
    44 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY Chelsea
    London
    British81928860002

    KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Subordinated security agreement
    Créé le 08 nov. 2004
    Livré le 11 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the subordinated beneficiaries and each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the accounts and the collateral and the custodian agreements,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Computershare Trust Company of Canada (Subordinated Collateral Agent)
    Transactions
    • 11 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 03 août 2004
    Livré le 09 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from krupaco UK to the credit agreement beneficiaries and each of them, to the other creditor beneficiaries and each of them, to the other hedging creditor beneficiaries and each of them. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of it rights title and interest in and to the accounts and the collateral to the senior collateral agent. All of its rights title and interest in and to the custodian agreements to the senior collateral agent. By way of first floating charge for the benefit of the beneficiaries and each of them all its assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bny Trust Corporation (The Senior Collateral Agent)
    Transactions
    • 09 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Subordinated security agreement between the company and montreal trust company
    Créé le 06 août 1998
    Livré le 21 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities and obligations of the company to the subordinated beneficiaries, and each of them, under the subordinated guarantee, under the senior and the subordinated debt intercreditor agreement and the subordinated debt intercreditor agreement, and under each agreement or instrument to which the company is a party
    Brèves mentions
    The cash assets the custodian agreements and all property from time to time including the loan receivables and all other securities all dividends interest and other income therefrom and all claims in respect of those amounts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Montreal Trust Company (Subordinated Collateral Agent)
    Transactions
    • 21 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Subordinated security agreement between the company and montreal trust company
    Créé le 06 août 1998
    Livré le 21 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities and obligations of the company to the subordinated beneficiaries, and each of them, under the subordinated guarantee, under the senior and the subordinated debt intercreditor agreement and the subordinated debt intercreditor agreement, and under each agreement or instrument to which the company is a party
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest in and under the guernsey custodian agreement and the cash assets all property including the loan receivables and all other securities dividends interest other income and rights from or incidental to the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Montreal Trust Company (The Subordinated Collateral Agent)
    Transactions
    • 21 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 05 août 1998
    Livré le 21 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee, each other loan document and/or the other creditor hedging contracts
    Brèves mentions
    By way of assignment by way of security the collateral.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trust Company of Bank of Montreal(The "Senior Collateral Agent")
    Transactions
    • 21 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 05 août 1998
    Livré le 21 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee, each other loan document and/or the other creditor hedging contracts
    Brèves mentions
    By way of assignment all of its rights title and interest in and to the accounts and the collateral to the senior collateral agent; all of its rights title and interest in and to the custodian agreements to the senior collateral agent; by way of first floating charge all its assets not otherwise effectively mortgaged or charged by way of fixed mortgage charge or security interest.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trust Company of Bank of Montreal(The "Senior Collateral Agent")
    Transactions
    • 21 août 1998Enregistrement d'une charge (395)

    KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 déc. 2014Commencement of winding up
    24 déc. 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0