OFFICE PROPERTIES PL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | OFFICE PROPERTIES PL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03125437 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?
| Adresse du siège social | Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2018 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2019 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 oct. 2019 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 nov. 2019 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 oct. 2018 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Ms Joanne Constance Bushell en tant qu'administrateur le 17 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wayne David Berger en tant que directeur le 03 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2025 | 17 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2024 | 17 pages | LIQ03 | ||||||||||
Nomination de Mr. Wayne David Berger en tant qu'administrateur le 31 mai 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr. Gavin Steven Phillips en tant qu'administrateur le 31 mai 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Morris en tant que directeur le 31 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2023 | 17 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2022 | 17 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2021 | 20 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 sept. 2020 | 18 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter David Edward Gibson en tant que directeur le 28 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 6 Snow Hill London EC1A 2AY à Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW le 07 oct. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Démission d'un liquidateur | 3 pages | LIQ06 | ||||||||||
Démission d'un liquidateur | 3 pages | LIQ06 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Burwood Place London W2 2UT England à 6 Snow Hill London EC1A 2AY le 22 juil. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 10 pages | LIQ02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 18 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2017 | 14 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSHELL, Joanne Constance | Administrateur | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | South Africa | British | 341942760001 | |||||||||
| PHILLIPS, Gavin Steven, Mr. | Administrateur | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | British | 324092780001 | |||||||||
| CAVE, Ian Bruce | Secrétaire | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | British | 102741680001 | ||||||||||
| CROSSLEY, James Daniel | Secrétaire | 34 Bellevue Road CM12 9HB Billericay Essex | British | 29059900001 | ||||||||||
| CITY GROUP PLC | Secrétaire | City Road EC1Y 2AG London 30 England |
| 35794270004 | ||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| PITSEC LIMITED | Secrétaire | Castle Street RG1 7SR Reading 47 England |
| 38734010001 | ||||||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Administrateur | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||||||
| BERGER, Wayne David, Mr. | Administrateur | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | Canadian | 323759890001 | |||||||||
| BIBRING, Michael Albert | Administrateur | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||||||
| BLURTON, Andrew Francis | Administrateur | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 53724380001 | |||||||||
| BOURNE, Graham Alexander | Administrateur | Le Roccabella 24 Avenue Princess Grace Monte Carlo 98000 Monaco | United Kingdom | British | 76871220004 | |||||||||
| BOURNE, Robert Anthony | Administrateur | 100 Cheyne Walk SW10 0DQ London | British | 70526160001 | ||||||||||
| BOUVIER, Alain Charles Patrice | Administrateur | 32 Earls Court Square SW5 9DQ London | England | British | 24106110001 | |||||||||
| BURROW, Robert Philip | Administrateur | 67 Brook Street W1K 4NJ London | England | British | 97252420005 | |||||||||
| CHENERY, Richard James | Administrateur | Lower Slaughter GL54 2HP Cheltenham The Manor Cottage Gloucestershire United Kingdom | England | British | 146075610001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Administrateur | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Administrateur | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | England | British | 235422380001 | |||||||||
| HARRISON, John William | Administrateur | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | 69263980002 | |||||||||
| MARSHALL, David Courtnall | Administrateur | Savannah House 32 Sherwood Road 4051 Durban North South Africa | South Africa | British | 132056360001 | |||||||||
| MORRIS, Richard | Administrateur | Burwood Place W2 2UT London 1 England | England | British | 190653350001 | |||||||||
| MYERSON, Brian Alan | Administrateur | 52 Winnington Road N2 0TY London | British | 63023520001 | ||||||||||
| PARKER, Christopher John | Administrateur | Hill Place Station Road CM8 3JN Wickham Bishops Essex | British | 8218630001 | ||||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Administrateur | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Administrateur | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| SANDERSON, Eric Fenton | Administrateur | 10 Harelaw Road EH13 0DR Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 126848980001 | |||||||||
| SHASHOU, Joseph Saleem | Administrateur | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | 51723030002 | |||||||||
| SINGH, Jagtar | Administrateur | West Garden Place Kendal Street W2 2AQ London 1 | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||||||
| STARN, William Robert | Administrateur | City Road EC1Y 2AG London 30 | England | American | 154007330001 | |||||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 | |||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Administrateur | 120 East Road N1 6AA London | 38524190001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marley Acquisitions Limited | 11 juil. 2017 | Burwood Place W2 2UT London 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mwb Serviced Office Holdings Limited (In Liquidation) | 06 avr. 2016 | Little New Street EC4A 3TR London Hill House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
OFFICE PROPERTIES PL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Créé le 01 août 2008 Livré le 13 août 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Entire right, title and interest in and to the 46,951,379 ordinary shares with a nominal value of £0.01 in the capital of mwb business exchange PLC together with all other shares in the capital of mwb business exchange PLC see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 31 mars 2005 Livré le 14 avr. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 03 juin 2003 Livré le 16 juin 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all inter-company debts. All the chargor's right, title and interest, present and future, in and to all inter-company debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over shares | Créé le 07 août 2002 Livré le 14 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Subordination agreement | Créé le 30 mai 2002 Livré le 10 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any amounts held on trust for the agent towards the payment of all the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Subordination deed between 140 park lane limited flatford limited and flatford (no.2) limited as the obligors the company and nwb (park lane) limited as original junior creditors and the bank | Créé le 08 janv. 2002 Livré le 18 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A security interest over the "junior liabilities". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Share charge | Créé le 28 août 1997 Livré le 12 sept. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mwb (warwick road) limited to the chargee in connection with the loan agreement or any security document | |
Brèves mentions By way of fixed charge the investments and all dividends interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 févr. 1996 Livré le 09 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
OFFICE PROPERTIES PL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0