OFFICE PROPERTIES PL LIMITED

OFFICE PROPERTIES PL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOFFICE PROPERTIES PL LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03125437
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Uhy Hacker Young Llp Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MWB PROPERTY LIMITED01 juil. 200801 juil. 2008
    MARYLEBONE WARWICK BALFOUR GROUP PLC01 juil. 199701 juil. 1997
    EX-LANDS PROPERTIES PLC08 nov. 199508 nov. 1995

    Quels sont les derniers comptes de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2018
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 oct. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 nov. 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 oct. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Ms Joanne Constance Bushell en tant qu'administrateur le 17 oct. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Wayne David Berger en tant que directeur le 03 oct. 2025

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2025

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2024

    17 pagesLIQ03

    Nomination de Mr. Wayne David Berger en tant qu'administrateur le 31 mai 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Gavin Steven Phillips en tant qu'administrateur le 31 mai 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Morris en tant que directeur le 31 mai 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2023

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2022

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2021

    20 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 sept. 2020

    18 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Peter David Edward Gibson en tant que directeur le 28 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 6 Snow Hill London EC1A 2AY à Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW le 07 oct. 2019

    2 pagesAD01

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Changement d'adresse du siège social de 1 Burwood Place London W2 2UT England à 6 Snow Hill London EC1A 2AY le 22 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 21 juin 2019

    LRESEX

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name20 juin 2019

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2017

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUSHELL, Joanne Constance
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    Administrateur
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    South AfricaBritish341942760001
    PHILLIPS, Gavin Steven, Mr.
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    Administrateur
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    EnglandBritish324092780001
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    British102741680001
    CROSSLEY, James Daniel
    34 Bellevue Road
    CM12 9HB Billericay
    Essex
    Secrétaire
    34 Bellevue Road
    CM12 9HB Billericay
    Essex
    British29059900001
    CITY GROUP PLC
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    England
    Secrétaire
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1443918
    35794270004
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    PITSEC LIMITED
    Castle Street
    RG1 7SR Reading
    47
    England
    Secrétaire
    Castle Street
    RG1 7SR Reading
    47
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2451677
    38734010001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Administrateur
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BERGER, Wayne David, Mr.
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    Administrateur
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Uhy Hacker Young Llp
    EnglandCanadian323759890001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    EnglandBritish53724380001
    BOURNE, Graham Alexander
    Le Roccabella
    24 Avenue Princess Grace
    Monte Carlo
    98000
    Monaco
    Administrateur
    Le Roccabella
    24 Avenue Princess Grace
    Monte Carlo
    98000
    Monaco
    United KingdomBritish76871220004
    BOURNE, Robert Anthony
    100 Cheyne Walk
    SW10 0DQ London
    Administrateur
    100 Cheyne Walk
    SW10 0DQ London
    British70526160001
    BOUVIER, Alain Charles Patrice
    32 Earls Court Square
    SW5 9DQ London
    Administrateur
    32 Earls Court Square
    SW5 9DQ London
    EnglandBritish24106110001
    BURROW, Robert Philip
    67 Brook Street
    W1K 4NJ London
    Administrateur
    67 Brook Street
    W1K 4NJ London
    EnglandBritish97252420005
    CHENERY, Richard James
    Lower Slaughter
    GL54 2HP Cheltenham
    The Manor Cottage
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lower Slaughter
    GL54 2HP Cheltenham
    The Manor Cottage
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish146075610001
    GIBSON, Peter David Edward
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    Administrateur
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish139640170001
    GIBSON, Peter David Edward
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    Administrateur
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    EnglandBritish235422380001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Administrateur
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    MARSHALL, David Courtnall
    Savannah House
    32 Sherwood Road
    4051 Durban North
    South Africa
    Administrateur
    Savannah House
    32 Sherwood Road
    4051 Durban North
    South Africa
    South AfricaBritish132056360001
    MORRIS, Richard
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Administrateur
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    EnglandBritish190653350001
    MYERSON, Brian Alan
    52 Winnington Road
    N2 0TY London
    Administrateur
    52 Winnington Road
    N2 0TY London
    British63023520001
    PARKER, Christopher John
    Hill Place Station Road
    CM8 3JN Wickham Bishops
    Essex
    Administrateur
    Hill Place Station Road
    CM8 3JN Wickham Bishops
    Essex
    British8218630001
    ROBOTHAM, John Michael
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    Administrateur
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    EnglandBritish3914540001
    ROBOTHAM, John Michael
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    Administrateur
    Brickwall Farmhouse
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    EnglandBritish3914540001
    SANDERSON, Eric Fenton
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish126848980001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Administrateur
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    Administrateur
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    United KingdomBritish121710890001
    STARN, William Robert
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    Administrateur
    City Road
    EC1Y 2AG London
    30
    EnglandAmerican154007330001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OFFICE PROPERTIES PL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Marley Acquisitions Limited
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    11 juil. 2017
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mwb Serviced Office Holdings Limited (In Liquidation)
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    England
    06 avr. 2016
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Acts 1985-2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House - Uk
    Numéro d'enregistrement04129282
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    OFFICE PROPERTIES PL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 01 août 2008
    Livré le 13 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Entire right, title and interest in and to the 46,951,379 ordinary shares with a nominal value of £0.01 in the capital of mwb business exchange PLC together with all other shares in the capital of mwb business exchange PLC see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 14 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 03 juin 2003
    Livré le 16 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all inter-company debts. All the chargor's right, title and interest, present and future, in and to all inter-company debts.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 16 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 07 août 2002
    Livré le 14 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 14 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subordination agreement
    Créé le 30 mai 2002
    Livré le 10 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any amounts held on trust for the agent towards the payment of all the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subordination deed between 140 park lane limited flatford limited and flatford (no.2) limited as the obligors the company and nwb (park lane) limited as original junior creditors and the bank
    Créé le 08 janv. 2002
    Livré le 18 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A security interest over the "junior liabilities". See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 28 août 1997
    Livré le 12 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mwb (warwick road) limited to the chargee in connection with the loan agreement or any security document
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the investments and all dividends interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 12 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 févr. 1996
    Livré le 09 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OFFICE PROPERTIES PL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 juin 2019Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Douglas Ernle Money
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    practitioner
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    practitioner
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Brian N Johnson
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    practitioner
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    practitioner
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0