V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED

V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéV.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03135542
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED ?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Où se situe V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    V.V. EDINBURGH G.P. LIMITED13 janv. 199713 janv. 1997
    V.V. BROMBOROUGH G.P. LIMITED29 mai 199629 mai 1996
    PRICEHOLD LIMITED07 déc. 199507 déc. 1995

    Quels sont les derniers comptes de V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mars 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 sept. 2010

    5 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mars 2010

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 mars 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    10 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    6118210006
    ANDERSON, William Wallace
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    Administrateur
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    EnglandBritish2894560001
    CARPENTER, Mark Richard Charles
    62 Murray Road
    SW19 4PE Wimbledon
    Administrateur
    62 Murray Road
    SW19 4PE Wimbledon
    EnglandBritish69709970001
    ELY, Roger Benjamin
    53 Five Arches
    Orton Wistow
    PE2 6FQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    53 Five Arches
    Orton Wistow
    PE2 6FQ Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish69707840001
    GEIPEL FABER, Ute
    Robert-Koch Strasse
    Munchen
    80538
    Germany
    Administrateur
    Robert-Koch Strasse
    Munchen
    80538
    Germany
    German66364770002
    JARRETT, Desmond Mason
    19 Hambalt Road
    Clapham
    SW4 9EA London
    Administrateur
    19 Hambalt Road
    Clapham
    SW4 9EA London
    EnglandBritish72779980001
    KRONESTER, Karl Heinz
    Bertelestr 23
    Munich
    FOREIGN 81479
    Germany
    Administrateur
    Bertelestr 23
    Munich
    FOREIGN 81479
    Germany
    German69708410001
    HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    6118210006
    BEGGEROW, Ann Patricia
    56 St Peters Street
    N1 8JT London
    Secrétaire
    56 St Peters Street
    N1 8JT London
    British77468940002
    DAWS, Raymond Kenneth
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    Secrétaire
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    British54856640001
    FITZGERALD, John Edward
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Secrétaire
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Irish55701370001
    SIMMS, John Geoffrey
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    British49583890001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Secrétaire désigné
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BEGGEROW, Ann Patricia
    56 St Peters Street
    N1 8JT London
    Administrateur
    56 St Peters Street
    N1 8JT London
    British77468940002
    BRIGHT, Keith
    5 Bateman Road
    Croxley Green
    WD3 3BL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Bateman Road
    Croxley Green
    WD3 3BL Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish65764440001
    BUSHNELL, Patrick James
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish26791960001
    BYSH, Rodney Alexander
    Wiesenstrasse 33
    60385 Frankfurt
    Germany
    Administrateur
    Wiesenstrasse 33
    60385 Frankfurt
    Germany
    British45848330001
    DAWS, Raymond Kenneth
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    Administrateur
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    British54856640001
    FITZGERALD, John Edward
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Administrateur
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Irish55701370001
    MUSSENDEN, Paul
    75 Camborne Avenue
    Ealing
    W13 9QZ London
    Administrateur
    75 Camborne Avenue
    Ealing
    W13 9QZ London
    British74707900001
    SIMMS, John Geoffrey
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    British49583890001
    SMITH, Andrew Richard Ingram
    15 Hurst Farm Road
    RH19 4DQ East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    15 Hurst Farm Road
    RH19 4DQ East Grinstead
    West Sussex
    British71449570001
    UNDERHILL, Anthony Owen
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    Administrateur
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    British80855550001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Administrateur désigné
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Administrateur désigné
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rental assignation
    Créé le 29 juil. 2002
    Livré le 07 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Certain facilities made available to the company as partner of and trustee for the firm of V.V. edinburgh LP by the chargee
    Brèves mentions
    The company's whole entitlement to receive from each of the tenants and/or licensees (together the "tenants") for the time being under all leases and/or occupational licences from time to time of parts of all and whole the subjects k/a and forming the spectrum building 55 blythswood street glasgow. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 07 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 9TH july 2002
    Créé le 09 juil. 2002
    Livré le 19 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company as partner of and trustee for the firm of V.V. edinburgh L.P. and/or the said firm of V.V. edinburgh L.P. to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The spectrum building 55 blythswood street glasgow t/nos: GLA138423 GLA140728. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 19 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 04 juil. 2002
    Livré le 16 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking property and assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 16 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An account charge and assignment by way of security
    Créé le 04 juil. 2002
    Livré le 16 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in and to the account and the deposit. By way of assignment all its right, title and interest in and to the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 16 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Assignation of rental assignations
    Créé le 14 oct. 1999
    Livré le 26 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Miller house 18/20 george street edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 26 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of standard security
    Créé le 06 oct. 1999
    Livré le 09 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation
    Brèves mentions
    The company's whole entitlement to receive from each of the tenants for the time being under the leases of the basement groun and first floors of miller house 18/20 george street edinburgh.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 09 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental assignation
    Créé le 27 sept. 1999
    Livré le 09 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Certain facilities made available to the company (as partner and trustee for the firm V.V. edinburgh L.P.) by the chargee
    Brèves mentions
    The company's whole entitlement to receive from each of the tenants for the time being under the leases of the second, third, fourth, fifth and sixth floor office premises forming 18-20 george street, edinburgh.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 09 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental assignation
    Créé le 13 févr. 1998
    Livré le 14 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Certain facilities made availible to the company (as partner of and trustee for the firm V.V. edinburgh L.P.) by the chargee
    Brèves mentions
    The company's whole entitlement to receive from each of the tenants for the time being under the leases of the basement ground and first floors of miller house 18/20 george street edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transactions
    • 14 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Accounts charge and assignment by way of security
    Créé le 18 oct. 1996
    Livré le 28 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "security documrents" (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in the "accounts" being the deposit account and the sinking fund established under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 28 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 18 oct. 1996
    Livré le 28 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    Floating charge over all property undertaking rights benefits and assets of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 28 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental assignation
    Créé le 16 oct. 1996
    Livré le 29 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    The company's whole entitlement to receive from each of the tenants )together the tenants) for the time being under the leases of parts 18 18A 18B 18C & 20 george street edinburgh all rents and other sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transactions
    • 29 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21/10/96
    Créé le 16 oct. 1996
    Livré le 29 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities now due or to become due from the company as partner of and trustee for the firm of V.V. edinburgh LP pursuant to the terms of any loan agreement to be dated 18/10/96 (or within 7 days of that date)
    Brèves mentions
    All and whole the office & banking premises k/a forming miller house 18-20 george street edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transactions
    • 29 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    V.V. GLASGOW (NO. 1) G.P. LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 mars 2009Commencement of winding up
    04 août 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0