SATURN BOOKS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SATURN BOOKS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03137579 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SATURN BOOKS LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 Gower Street WC1E 6HD London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SATURN BOOKS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2015 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SATURN BOOKS LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour SATURN BOOKS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Zana Samantha Hanks en tant que secrétaire le 19 mai 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Allan Conan Sams en tant que secrétaire le 26 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Polly Powell en tant qu'administrateur le 01 janv. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Old Magistrates Court 10 Southcombe Street London W14 0RA* le 07 juil. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robin Wood en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Proffit en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SATURN BOOKS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANKS, Zana Samantha | Secrétaire | Gower Street WC1E 6HD London 1 | 197804940001 | |||||||
POWELL, Polly Augusta Marchant | Administrateur | Gower Street WC1E 6HD London 1 England | England | British | Publisher | 110229300002 | ||||
NESS, Robert James | Secrétaire | 247 Icknield Way SG6 4UE Letchworth Hertfordshire | British | 33929080001 | ||||||
PHILLIPS, Kevin | Secrétaire | 2 Honour Close Bierton HP20 2XN Aylesbury Buckinghamshire | British | Accountant | 44857580001 | |||||
POTTERELL, Clive Ronald | Secrétaire | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | British | 3182530002 | ||||||
SAMS, Allan Conan | Secrétaire | Gower Street WC1E 6HD London 1 England | British | Lawyer | 107693020001 | |||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
BROWN, Cameron Michael | Administrateur | 10 Hillside SW19 4NH London | United Kingdom | British | Company Director | 1654670001 | ||||
BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson | Administrateur | Bullrush Farm Hillgrove Lurgashall GU28 9EP Petworth West Sussex | United Kingdom | British | Financial Director | 36186210001 | ||||
COLLINS, Samuel Alexander Mark | Administrateur | 71 Cadogan Square SW1 London | British | Publisher | 63626140001 | |||||
JAITLY, Suneel | Administrateur | 27 Ferndown Gardens KT11 2BH Cobham Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 44857620002 | ||||
LENTON, Paul Richard | Administrateur | 27 Great Bushey Drive Totteridge N20 8QN London | England | British | Finance Director | 82173510001 | ||||
MESSHAM, Elizabeth Joanne | Administrateur | 82 Elms Road Clapham SW4 9EW London | British | Company Director | 62020600001 | |||||
NEEDLEMAN, John Elliot | Administrateur | Kerry 20 Christchurch Crescent WD7 8AH Radlett Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 20117690001 | |||||
PHILLIPS, Kevin | Administrateur | 13 Saint Albans Road NG6 9JQ Nottingham | British | Accountant | 44857580003 | |||||
PROFFIT, David Macer, Mr. | Administrateur | Old Magistrates Court 10 Southcombe Street W14 0RA London | United Kingdom | British | Publisher | 109190190002 | ||||
SANDERSON, Charles | Administrateur | 105 Castlehaven Road Camden NW1 8SJ London | British | Finance Director | 88028580001 | |||||
STRACHAN, David Alistair | Administrateur | Summerhill Cottage Summerhill Road DA1 2LP Dartford Kent | United Kingdom | British | Financial Director | 56866560001 | ||||
WOOD, Robin Lee Knoyle | Administrateur | Old Magistrates Court 10 Southcombe Street W14 0RA London | Uk | British | Publisher | 110229220004 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
SATURN BOOKS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Créé le 13 mars 2007 Livré le 16 mars 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 23 nov. 2005 Livré le 09 déc. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 09 avr. 2001 Livré le 26 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Stock trust deed and charge over assets | Créé le 22 avr. 1997 Livré le 01 mai 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti In favour of the chargee all monies due in relation to the £367,000 10% fixed rate loan stock issued by the promotional reprint company limited and secured by the charge | |
Brèves mentions By way of a fixed charge all intellectual property rights belonging to the company. By way of a floating charge the company's undertaking and all their other property assets and undertakings both present and future including any uncalled capital together with any assets and rights mortgaged or charged under the fixed charge if and so far as such mortgage or charge is ineffective as a fixed charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 14 févr. 1996 Livré le 17 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0