SATURN BOOKS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSATURN BOOKS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03137579
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SATURN BOOKS LIMITED ?

    • Édition de livres (58110) / Information et communication

    Où se situe SATURN BOOKS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Gower Street
    WC1E 6HD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SATURN BOOKS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MARKETLIST LIMITED13 déc. 199513 déc. 1995

    Quels sont les derniers comptes de SATURN BOOKS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SATURN BOOKS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SATURN BOOKS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 déc. 2015

    État du capital au 21 déc. 2015

    • Capital: GBP 102
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2015

    6 pagesAA

    Nomination de Mrs Zana Samantha Hanks en tant que secrétaire le 19 mai 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Allan Conan Sams en tant que secrétaire le 26 mars 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2015

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 102
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2014

    6 pagesAA

    Nomination de Ms Polly Powell en tant qu'administrateur le 01 janv. 2014

    2 pagesAP01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de * Old Magistrates Court 10 Southcombe Street London W14 0RA* le 07 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Robin Wood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Proffit en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 janv. 2014

    État du capital au 17 janv. 2014

    • Capital: GBP 102
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011

    6 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de SATURN BOOKS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HANKS, Zana Samantha
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    Secrétaire
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    197804940001
    POWELL, Polly Augusta Marchant
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    Administrateur
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    EnglandBritishPublisher110229300002
    NESS, Robert James
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    British33929080001
    PHILLIPS, Kevin
    2 Honour Close
    Bierton
    HP20 2XN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    2 Honour Close
    Bierton
    HP20 2XN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishAccountant44857580001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SAMS, Allan Conan
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    Secrétaire
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    BritishLawyer107693020001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BROWN, Cameron Michael
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    Administrateur
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    United KingdomBritishCompany Director1654670001
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritishFinancial Director36186210001
    COLLINS, Samuel Alexander Mark
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    Administrateur
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    BritishPublisher63626140001
    JAITLY, Suneel
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    Administrateur
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director44857620002
    LENTON, Paul Richard
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    Administrateur
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    EnglandBritishFinance Director82173510001
    MESSHAM, Elizabeth Joanne
    82 Elms Road
    Clapham
    SW4 9EW London
    Administrateur
    82 Elms Road
    Clapham
    SW4 9EW London
    BritishCompany Director62020600001
    NEEDLEMAN, John Elliot
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant20117690001
    PHILLIPS, Kevin
    13 Saint Albans Road
    NG6 9JQ Nottingham
    Administrateur
    13 Saint Albans Road
    NG6 9JQ Nottingham
    BritishAccountant44857580003
    PROFFIT, David Macer, Mr.
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Administrateur
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    United KingdomBritishPublisher109190190002
    SANDERSON, Charles
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    Administrateur
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    BritishFinance Director88028580001
    STRACHAN, David Alistair
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    Administrateur
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    United KingdomBritishFinancial Director56866560001
    WOOD, Robin Lee Knoyle
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Administrateur
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    UkBritishPublisher110229220004
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    SATURN BOOKS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 mars 2007
    Livré le 16 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 nov. 2005
    Livré le 09 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chrysalis Group PLC
    Transactions
    • 09 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 09 avr. 2001
    Livré le 26 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chrysalis Books PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Stock trust deed and charge over assets
    Créé le 22 avr. 1997
    Livré le 01 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all monies due in relation to the £367,000 10% fixed rate loan stock issued by the promotional reprint company limited and secured by the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all intellectual property rights belonging to the company. By way of a floating charge the company's undertaking and all their other property assets and undertakings both present and future including any uncalled capital together with any assets and rights mortgaged or charged under the fixed charge if and so far as such mortgage or charge is ineffective as a fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Limecourt Investments Limited
    Transactions
    • 01 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 17 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 17 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0