ATKINS & CRIPPS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéATKINS & CRIPPS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03140130
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ATKINS & CRIPPS LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe ATKINS & CRIPPS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    UHY HACKER YOUNG LLP
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    EW1 YW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ATKINS & CRIPPS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    YANKEE LIMITED15 déc. 199515 déc. 1995

    Quels sont les derniers comptes de ATKINS & CRIPPS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ATKINS & CRIPPS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mai 2011

    7 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Kemp House Cumnor Hill Oxford Oxfordshire OX2 9PH le 14 déc. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 nov. 2010

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 janv. 2010

    État du capital au 11 janv. 2010

    • Capital: GBP 3,200,001
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    17 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    19 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    legacy

    3 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de ATKINS & CRIPPS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    English15662110002
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    FINEMAN, Simon
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    Administrateur
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    EnglandBritish61133550002
    DAVIES, Gareth
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British71865070001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    British50701840001
    PHILLIPS, Lawrence Stephen
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British11800250003
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Secrétaire désigné
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    BARRINGER, Paul Brandon
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    Administrateur
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    American34440990001
    BARRINGER, Victor
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    Administrateur
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    American50712820003
    BOSTON, Neil Moir, Mr.
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish113486000001
    CAMPOLL, Henry William
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    Administrateur
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    American54149770001
    CONGER, Stephen Halsey
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    Administrateur
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    American47437230001
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    GORMAN, James John Stuart
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    British47435900001
    HAYWOOD, David James
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    Administrateur
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    United KingdomBritish47436450002
    HIPKIN, Ian Robert
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    British78621800001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritish50701840001
    MCGAGIN, Timothy A
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Administrateur
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Usa40432680002
    SEAY, Ronald Frederick
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    Administrateur
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    American47437050001
    THEWLIS, Clive Roger
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritish125543430001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Administrateur désigné
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    ATKINS & CRIPPS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 07 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 28 janv. 2005
    Livré le 01 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 50-54, lancaster way, ely, cambridgeshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 févr. 2004
    Livré le 04 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 07 sept. 2000
    Livré le 13 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 sept. 2000
    Livré le 13 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 95 london road bishops stortford t/n HD316227. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 févr. 2000
    Livré le 10 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the deposit of £6,500 held in an interest bearing deposit account in accordance with the deed.
    Personnes ayant droit
    • Southend Property Management Limited
    Transactions
    • 10 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 févr. 2000
    Livré le 10 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £6,500 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Units 1 & 2 tamar view industrial estate saltash.
    Personnes ayant droit
    • Southend Property Management Limited
    Transactions
    • 10 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 03 avr. 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £13,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the deed
    Brèves mentions
    By way of legal charge the sum of £13,000 or such other monies held from time to time pursuant to the deed.
    Personnes ayant droit
    • Southend Property Management Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 janv. 1996
    Livré le 09 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    L/H-property k/a sheffield park sawmills uckfield east sussex. F/h-unit 5 bilston industrial estate bilston west midlands t/n-WM421694. F/h-95 london road bishop's stortford t/n-HD316227. F/h-9 burrington way plymouth t/n-DN241029. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Coastal Lumber Company
    Transactions
    • 09 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture created by the company formerly known as yankee limited
    Créé le 22 janv. 1996
    Livré le 26 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Boston
    Transactions
    • 26 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ATKINS & CRIPPS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 nov. 2010Commencement of winding up
    01 oct. 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    practitioner
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    practitioner
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0