BROADOAK FARMING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BROADOAK FARMING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03143220 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BROADOAK FARMING LIMITED ?
Adresse du siège social | Gibbs Building 215 Euston Road NW1 2BE London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BROADOAK FARMING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 07 janv. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour BROADOAK FARMING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Anthony Argyle en tant que directeur le 28 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 12 févr. 2019
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 07 janv. 2018 | 9 pages | AA | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 8a, Longside Barns Jebb Lane Haigh Barnsley S75 4BS England à Gibbs Building 215 Euston Road London NW1 2BE le 01 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 08 janv. 2017 | 9 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Farmcare Trading Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Carolyn Kloet en tant que secrétaire le 29 juin 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Cossar en tant que secrétaire le 29 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 6th Floor Parsonage Chambers 3 the Parsonage Manchester M3 2HW à Unit 8a, Longside Barns Jebb Lane Haigh Barnsley S75 4BS le 28 oct. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 10 janv. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michelle Mcnally en tant que directeur le 19 août 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Robert Anthony Argyle en tant qu'administrateur le 17 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michelle Mcnally le 01 juin 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Quinn le 01 juin 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BROADOAK FARMING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLOET, Carolyn | Secrétaire | c/o Christine Hill 215 Euston Road NW1 2BE London Gibbs Building England | 234642430001 | |||||||
QUINN, Richard | Administrateur | 215 Euston Road NW1 2BE London Gibbs Building England | England | British | Head Of Farms | 176251640001 | ||||
COSSAR, Andrew | Secrétaire | c/o Christine Hill 215 Euston Road NW1 2BE London Gibbs Building United Kingdom | 189995460001 | |||||||
HADDEN, David James | Secrétaire | 18 Kelthorpe Close Ketton PE9 3RS Stamford Lincolnshire | British | Company Director | 947170003 | |||||
HUGHES, Lesley Jane | Secrétaire | 3 Chestnut Avenue Caversham RG4 0NS Reading | British | 48865050001 | ||||||
SELLERS, Caroline Jane | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | 45801060004 | ||||||
STEVENSON, James David | Secrétaire | Flat 33 100 Drayton Park N5 1NF London | British | 76020470002 | ||||||
THACKRAY, Simon Nicholas Jon | Secrétaire | The Thatched Cottage Glapthorn PE8 5BE Oundle Northamptonshire | British | 56832050001 | ||||||
ARGYLE, Robert Anthony | Administrateur | 215 Euston Road NW1 2BE London Gibbs Building England | England | British | Finance Director | 201667680001 | ||||
BEARDWOOD, Joseph | Administrateur | 57 Blenheim Gardens KT2 7BT Kingston Upon Thames Surrey | British | Controller Commercial Division | 48786700001 | |||||
BLAZIC, Iliya William | Administrateur | c/o Christine Hill 215 Euston Road NW1 2BE London Gibbs Building England | United Kingdom | Australian | Investment Executive | 187798270001 | ||||
CALVERT, Michael | Administrateur | Iscennen House 8 Chapel Lane Gaddesby LE7 4WB Leicester Leicestershire | British | General Manager Agriculture | 116728150001 | |||||
HADDEN, David James | Administrateur | 18 Kelthorpe Close Ketton PE9 3RS Stamford Lincolnshire | British | Company Director | 947170003 | |||||
JOHNSON, Charles Peter | Administrateur | Pages Farm Stebbing CM6 3BT Dunmow Essex | England | British | Company Director | 2664330001 | ||||
JOHNSTON, Angela Rosemary | Administrateur | 2 Simmonds Street Holybrook RG1 6QF Reading Berkshire | British | Solicitor | 45802770001 | |||||
JONES, Katherine Jane | Administrateur | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Product Development And Farms | 169239110001 | ||||
MARCUS, Fraser Eliot | Administrateur | 3 Graham Terrace SW1W 8JE London | American British | Investment Banker | 43903260001 | |||||
MCALLISTER, Malcolm Glen | Administrateur | Hillcrest House Bury Road CO10 9QG Lavenham Suffolk | United Kingdom | British | Company Director | 159639950001 | ||||
MCNALLY, Michelle | Administrateur | Parsonage Chambers 3 The Parsonage M3 2HW Manchester 6th Floor England | England | British | Head Of Finance | 190923370001 | ||||
MCNALLY, Michelle | Administrateur | Angel Square M60 0AG Manchester 1 England | England | British | Head Of Finance | 190923370001 | ||||
MONKS, Ian Mighell | Administrateur | c/o Christine Hill 215 Euston Road NW1 2BE London Gibbs Building England | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 62549680002 | ||||
PEREIRA GRAY, Peter John | Administrateur | c/o Christine Hill 215 Euston Road NW1 2BE London Gibbs Building England | United Kingdom | British | Managing Director Investments | 190033060001 | ||||
PRESCOTT, William Alan | Administrateur | Woodlea 11 Wellington Road Atherton M49 9HE Manchester | British | Deputy Chief Executive | 8101580001 | |||||
RANKIN, Yvonne Rose | Administrateur | The Maples Holmes Chapel Road WA16 9RD Over Peover Cheshire | British | Chief Operating Officer | 107621540001 | |||||
SOUTHERN, John | Administrateur | 3 Kershaw Grove SK11 8TN Macclesfield Cheshire | British | Accountant | 106557240001 | |||||
TACON, Christine Mary | Administrateur | New Century House Manchester M60 4ES | England | British | General Manager Farming | 76748660003 | ||||
TURNER, David John | Administrateur | 134 Hampton Road TW2 5QR Twickenham Middlesex | British | Company Director | 35572190001 | |||||
WELLENS, David Hugh | Administrateur | Axholme Woodbourne Road New Mills SK22 3JX High Peak Derbyshire | England | British | Divisional Accoountant | 33860330002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BROADOAK FARMING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmcare Trading Limited | 06 avr. 2016 | Jebb Lane Haigh S75 4BS Barnsley Unit 8a, Longside Barns England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
BROADOAK FARMING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Keyman assignation | Créé le 18 sept. 1996 Livré le 01 oct. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Policy no: T870189 dated 31 january 1996 the sum of £1,000,000 together with the whole sums assured thereby and all bonuses which may arise thereunder. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 23 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0