KUMASI (UK) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKUMASI (UK) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03143899
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KUMASI (UK) LTD ?

    • (7499) /

    Où se situe KUMASI (UK) LTD ?

    Adresse du siège social
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KUMASI (UK) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour KUMASI (UK) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2010

    État du capital au 05 janv. 2010

    • Capital: USD 1,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Sean Gay en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sean Macdonald Gay le 15 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Lewis Bruning le 15 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Harrison Baines le 15 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Doris Sharp le 15 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    9 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    9 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    9 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2002

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de KUMASI (UK) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHARP, Doris
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    Secrétaire
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    British1669500001
    BAINES, Robert Harrison
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    Administrateur
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    United KingdomBritishCompany Director46182260008
    BRUNING, Michael Lewis
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    Administrateur
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    EnglandBritishFinancial Director19697160001
    BRUNING, Michael Lewis
    Chartstone 1 Tally Road
    Limpsfield Chart
    RH8 0TG Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    Chartstone 1 Tally Road
    Limpsfield Chart
    RH8 0TG Oxted
    Surrey
    British19697160001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    GAY, Sean Macdonald
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    Administrateur
    Marc House
    13-14 Great Saint Thomas
    EC4V 2BB Apostle London
    EnglandBritishCompany Director2326160001
    PAUS, Christopher
    93 Abbotsbury Road
    W14 8EP London
    Administrateur
    93 Abbotsbury Road
    W14 8EP London
    EnglandNorwegianCompany Director39784100002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    KUMASI (UK) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge agreement
    Créé le 15 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity provision of clause 7.4 of the financial agreement and/or the security documents and/or in connection therewith
    Brèves mentions
    All amounts credited to or standing to the credit of the us$ bank account no. 1100082481 and any amendment or replacement thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Insurance assignment agreement
    Créé le 15 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity provision of clause 7.4 of the financial agreement and/or the security documents and/or in connection therewith
    Brèves mentions
    All policies and contracts of insurance in relation to M.V. "kribi".
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Earnings assignment agreement
    Créé le 15 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity provisions of clause 7.4 of the financial agreement dated 21ST april 1999 and/or the security oocuments and/or in connection therewith
    Brèves mentions
    All freights hire and any other amounts whatsover earned by or payable to or for the account of the company or it's agents arising out of the ownership management and/or operation of the ship M.V. "kribi". See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenants
    Créé le 15 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemity provision of clause 7.4 of the financial agreement and/or under the security documents and/or in connection with the deed of covenants
    Brèves mentions
    M.V. "kribi" registered in the name of the company under the laws of the isle of man at the port of douglas under O.N. 732652 and all equipment and possesions thereto under the deed any share and interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig -Holstein Girozentrale
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First priority statutory mortgage
    Créé le 15 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the financial agreement dated 21ST april 1999 between the bank and the company and the deed of covenants dated 15TH october 1999 between the company and the bank
    Brèves mentions
    M.V. "kribi" registered in the name of the company at the port of douglas under the laws of the isle of man with O.N. 732652 all shares therein and in her boats and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holsten Girozentrale
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First priority general assignment
    Créé le 16 janv. 1996
    Livré le 24 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $12,000,000 or its deutsche marks equivalent and all other monies due or to become due from the company, kukawa (UK) LTD and ot africa line limited to the chargee under the terms of the agreement and the rest of the security documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest present and future in and to:- 1) the time charterparty dated 5 january 1996 made between the company and ot africa line limited and any other charter or contract of employment in respect of the company's vessel "kumasi". See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank As
    Transactions
    • 24 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First statutory isle of man mortgage and deed of covenant
    Créé le 16 janv. 1996
    Livré le 24 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $12,000,000 or its deutsche marks equivalent and all other monies due from the company to the chargee, kukawa (UK) LTD and ot africa line limited to the chargee under the terms of the agreement and the rest of the security documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest present and future to and in the whole of the company's motor vessel "kumasi" registered under the british flag at the port of douglas, isle of man, including her machinery, outfit, spare gear, fuel etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank As
    Transactions
    • 24 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Loan facility agreement
    Créé le 12 janv. 1996
    Livré le 24 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $12,000,000 or its deutsche marks equivalent and all other monies due or to become due from the company, kukawa (UK) LTD and ot africa line limited to the chargee under the terms of the agreement and the rest of the security documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    Any and all accounts with any office or branch or with any subsidiary or holding company of the mortgagee held by the company.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank As
    Transactions
    • 24 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0