SHELFCO 1235 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHELFCO 1235 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03148337
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHELFCO 1235 LIMITED ?

    • autres activités d'impression n.c.a. (18129) / Industries manufacturières

    Où se situe SHELFCO 1235 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SHELFCO 1235 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GEMINI BRIGHTON LIMITED30 avr. 201330 avr. 2013
    ANDUS PRINT LIMITED19 janv. 199619 janv. 1996

    Quels sont les derniers comptes de SHELFCO 1235 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour SHELFCO 1235 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2019

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2017

    22 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2018

    20 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 27 mars 2015

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.18 attaché

    10 pages4.20

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2016

    20 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Unit a1 Dolphin Way Shoreham by Sea West Sussex BN43 6NZ à 2/3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE le 13 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Cessation de la nomination de David John Britton en tant que directeur le 20 mars 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Boyle en tant que directeur le 20 mars 2015

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 mars 2015

    État du capital au 10 mars 2015

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2014

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2013

    16 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed gemini brighton LIMITED\certificate issued on 14/05/14
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name14 mai 2014

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name14 mai 2014

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2014 au 31 janv. 2014

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 avr. 2014

    État du capital au 14 avr. 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2013 au 31 juil. 2013

    1 pagesAA01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed andus print LIMITED\certificate issued on 30/04/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name30 avr. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name30 avr. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SHELFCO 1235 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Owen
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    Secrétaire
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    165864810001
    CROPPER, Stephen Andrew
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    Administrateur
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    EnglandBritish38816830003
    HOLMES, Emma
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    British48967630002
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    British24756150004
    STARTCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    Secrétaire désigné
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    900009720001
    BOYLE, John
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    Administrateur
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    United KingdomBritish141437280001
    BRAZIER, Lynn Suzanne
    34 Rose Walk
    Goring By Sea
    BN12 4AU Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    34 Rose Walk
    Goring By Sea
    BN12 4AU Worthing
    West Sussex
    British59230810001
    BRITTON, David John
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    Administrateur
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    EnglandBritish68594390004
    HOLMES, Emma
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    Administrateur
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    British48967630002
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Administrateur
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    EnglandBritish24756150004
    KELLY, Ryan
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    Administrateur
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    United KingdomBritish152024020001
    NEWCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    Administrateur désigné
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    900009710001

    SHELFCO 1235 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 27 janv. 2011
    Livré le 29 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 juil. 2008
    Livré le 08 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 08 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 05 mars 2007
    Livré le 07 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 07 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 01 févr. 1999
    Livré le 12 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 47 highcroft villas brighton east sussex t/no's;-ESX33813 and ESX88672. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 1998
    Livré le 19 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • G E Capital Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 19 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 24 avr. 1996
    Livré le 08 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement (as defined therein) or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge (I) all debts, the subject of an agreement between the company and the chargee (ii) all other debts owing to the company and (iii) all rights in favour of the company related to or arising under any contract of sale giving rise to any such debt. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Factors Limited
    Transactions
    • 08 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 1997Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 17 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 05 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    47 highcroft villas brighton t/nos: ESX33813 and ESX88672. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SHELFCO 1235 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2015Commencement of winding up
    14 juin 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan James Beard
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    practitioner
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    John Walters
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    practitioner
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0