HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUDSON CAPITAL (SPH) LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03148655
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. ?

    Adresse du siège social
    Fairfax House
    15 Fulwood Place
    WC1V 6AY London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROM CAPITAL (SPH) LIMITED04 janv. 200804 janv. 2008
    STOCKSTAR PROPERTY HOLDINGS LIMITED27 août 199827 août 1998
    STOCKSTAR LIMITED19 janv. 199619 janv. 1996

    Quels sont les derniers comptes de HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Martin Hamilton Croft-Sharland le 15 mars 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew John Jenkins le 28 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 janv. 2013

    État du capital au 23 janv. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    14 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Martin Hamilton Croft-Sharland le 02 août 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew John Jenkins le 02 août 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Thomas Joseph Pearman le 02 août 2012

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Joseph Pearman le 02 août 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Hugh Macpherson Cameron Fraser le 02 août 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Charles Anthony Alcock le 02 août 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA

    legacy

    7 pagesMG01

    Résolutions

    Resolutions
    34 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2010 au 31 mars 2011

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    13 pagesAA

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 22 déc. 2010

    2 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 21 déc. 2010

    2 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 22 déc. 2010

    2 pages3.6

    Qui sont les dirigeants de HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEARMAN, Thomas Joseph
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    156863270001
    ALCOCK, Charles Anthony
    Floor Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector141993640001
    CROFT-SHARLAND, Richard Martin Hamilton
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor141629920025
    FRASER, Hugh Macpherson Cameron
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector157004960001
    JENKINS, Andrew
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor Marble Arch Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor Marble Arch Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector142929030001
    PEARMAN, Thomas Joseph
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector104558060003
    BURNEY, Daren Mark
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    Secrétaire
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    BritishDirector102580230005
    MORRIS, Martin Alan
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    BritishCompany Director13448160001
    SILVERMAN, Alan
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    CanadianEstate Agent46409830001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Secrétaire
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    150738050001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Secrétaire
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    150737080001
    THOMPSON, Peter Mckelvey
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    BritishAccountant97178760001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BURNEY, Daren Mark
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    Administrateur
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    United KingdomBritishDirector102580230005
    JACKMAN, Robert Maurice Henry
    38 Millfield Lane
    N6 6JB London
    Administrateur
    38 Millfield Lane
    N6 6JB London
    United KingdomBritishSurveyor5882990003
    LESTER, Michael Arthur
    405 Cockfosters Road
    EN4 0JS Hadley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    405 Cockfosters Road
    EN4 0JS Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishCompany Director16107200001
    MORRIS, Martin Alan
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director13448160001
    MURPHY, Peter Laurence
    42a Totteridge Common
    N20 London
    Administrateur
    42a Totteridge Common
    N20 London
    EnglandBritishCompany Director77374270003
    SILVERMAN, Alan
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    EnglandCanadianEstate Agent46409830001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Administrateur
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    EnglandEnglishDirector150726360001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Administrateur
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    EnglandEnglishDirector150726360001
    THOMPSON, Peter Mckelvey
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    BritishAccountant97178760001
    WHITTON, Robert David
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    Administrateur
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    EnglandBritishDirector141553070002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge over shares
    Créé le 21 nov. 2011
    Livré le 02 déc. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Full title guarantee as continuing security for the payment and discharge of the indebtedness charged to nationwide its entir right title and interest in and to the shares and their proceeds of sale. Number of shares in the guarantor - 215 (two hundred and fifteen). Denomination or type of shares - ordinary a shares see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 02 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge over deposit account
    Créé le 15 janv. 2009
    Livré le 16 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The balance for the time being on the following bank account - account no. 46114246 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 16 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 déc. 2007
    Livré le 27 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land being unit 2 martinfields business centre martinfields welwyn garden ci. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 27 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 127 mars 2010Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 119 mars 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2007
    Livré le 27 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit f trevithick roadwillow brook industrial estate corby northamptonshire t/no NN215139,f/h property k/a rippleside commercial estate barking essex t/no EGL363117,f/h property k/A1-17 marlow workshops tower hamlets london t/no EGL202466 (for details of further properties charged please refer to for. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 27 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 04 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property at rippleside commercial es. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 220 avr. 2010Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 219 mars 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 2
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 04 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property being unit f, trevithick road willowbrook industrial estate corby N. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 420 avr. 2010Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 419 mars 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 4
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 04 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 1-17 marlow workshops T. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 320 avr. 2010Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 313 août 2010Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 3
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 04 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit f, trvithick roadwillow brook industrial estate corby northamptonshire t/no NN215139. F/h property k/a rippleside commercial estate barking essex t/no EGL363117 and f/h property k/a 1-17 marlow workshops tower hamlets. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 05 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at unit 2 martinfields business centre martinfield welwyn garden city herts t/no HD263190. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 28 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 1-17 marlow workshops arnold circus tower hamlets london borough t/n EGL202466,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 28 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Rippleside commercial estate ripple road barking t/n EGL363117,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 28 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit f trevithick road willowbrook industrial estate corby northants t/n NN215139,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 29 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a land on the west side of trvithick road corby t/no: NN215139.
    Personnes ayant droit
    • Standard Bank Jersey Limited
    Transactions
    • 29 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 1998
    Livré le 01 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 1A-1C daleside road nottingham t/no;-NT34372 all buildings and fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lazard Brothers & Co. (Jersey) Limited
    Transactions
    • 01 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 janv. 1998
    Livré le 05 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F.h marshgate 16 marshgate lane stratford london E15 t/n NGL95958.
    Personnes ayant droit
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transactions
    • 05 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 janv. 1998
    Livré le 05 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a rippleside commercial estate,ripple road,barking,essex.t/no.EGL363117.
    Personnes ayant droit
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transactions
    • 05 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 janv. 1998
    Livré le 05 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a woodside industrial estate,works road,letchworth,herts.t/no.HD205102.
    Personnes ayant droit
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transactions
    • 05 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 16 déc. 1997
    Livré le 30 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a deed of guarantee dated 19TH september 1997 and/or under the terms of this second legal charge
    Brèves mentions
    Rippleside commercial estate ripple road barking t/n-EGL363117.
    Personnes ayant droit
    • Rothschild Trust Guernsey Limited
    Transactions
    • 30 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 sept. 1997
    Livré le 25 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a rippleside commercial estate all income and rights relating thereto proceeds of sale thereof and proceeds of all insurance floating charge undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • N.M.Rothschild & Sons (C.I.) Limited
    Transactions
    • 25 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    4Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0