AMEY DATEL GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMEY DATEL GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03152636
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMEY DATEL GROUP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AMEY DATEL GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMEY DATEL GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DATEL FERRANTI GROUP LIMITED30 janv. 199630 janv. 1996

    Quels sont les derniers comptes de AMEY DATEL GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour AMEY DATEL GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juin 2012

    État du capital au 21 juin 2012

    • Capital: GBP 10,504,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Melvyn Ewell le 30 nov. 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sherard Secretariat Services Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04

    legacy

    1 pages190a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    14 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    2 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de AMEY DATEL GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5615519
    109588620001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector36191090003
    HUI, Carol
    GU8
    Secrétaire
    GU8
    British72371980001
    SMITH, Michael John
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    Secrétaire
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    British61711420001
    TETLOW, John Richard
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Secretary68445840001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Richard Hawthorn
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCivil Servant56940900001
    BATCHELOR, Graeme Warwick
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    Administrateur
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director58892340002
    BRADBURY, Richard George
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    Administrateur
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    BritishGroup Commercial Director42234330002
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Administrateur
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    BritishDirector50174710001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Administrateur
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    BritishDirector50174710001
    HARRIS, Howard Daniel
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Administrateur
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    BritishDirector44607740001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    SpanishGroup Finance Director93348510004
    MCCARTNEY, Alan
    17 The Orchards
    WA16 0LS Pickmere
    Cheshire
    Administrateur
    17 The Orchards
    WA16 0LS Pickmere
    Cheshire
    BritishDirector118583390001
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Administrateur
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritishChartered Accountant152304230002
    MOGG, Charles Michael
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishCivil Engineer And Company Dir87961010001
    MORRIS, Keith Peter
    Keepers Cottage
    Lilac Avenue
    FY8 4LG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Administrateur
    Keepers Cottage
    Lilac Avenue
    FY8 4LG Lytham St. Annes
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector43135960002
    MURAD, Simon William
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    Administrateur
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector75114990001
    PEAT, Stephen Hedley
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    Administrateur
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    BritishDirector70137370001
    POWERS, Glenn Patrick
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    Administrateur
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    BritishCompany Director72486520001
    PUGH, Graham John
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    Administrateur
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    BritishMan. Dir24512450001
    ROBINSON, John Hamilton
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    Administrateur
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    AmericanEngineer69410760003
    STAPLES, Brian Lynn
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector55479560003
    SWEENEY, John Trevor
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    Administrateur
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant70137390001
    WILLIAMSON, Stephen
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    BritishDirector36188290001

    AMEY DATEL GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 14 mars 2003
    Livré le 26 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee on Behalf of the Finance Parties
    Transactions
    • 26 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juin 1998
    Livré le 17 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 10 oct. 1996
    Livré le 17 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0