TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03152729 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED ?
| Adresse du siège social | Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 08 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Gareth Russell Jacob en tant que directeur le 24 mars 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2025 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Daniel Stewart Wilson en tant que secrétaire le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 juil. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU United Kingdom à Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park Solihull B90 8AU le 14 juil. 2025 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Mr Arthur Ben Brenton en tant qu'administrateur le 15 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Ian John Mitchell en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2024 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Trevor David Thomas en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Gareth Russell Jacob en tant qu'administrateur le 13 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2023 au 31 mars 2023 | 1 pages | AA01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Daniel Stewart Wilson en tant que secrétaire le 31 mai 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Modification des détails de Twigden Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 août 2022 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de One St Peter's Square Manchester United Kingdom M2 3DE United Kingdom à Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU le 16 août 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Gary Bosley Phillips en tant que directeur le 15 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 81 Fountain Street Manchester M2 2EE England à One St Peter's Square Manchester United Kingdom M2 3DE le 05 août 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des détails de Twigden Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 août 2021 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de la nomination de Philip Higgins en tant que secrétaire le 28 mai 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Qui sont les dirigeants de TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTON, Arthur Ben | Administrateur | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | England | British | 306343990001 | |||||
| ARMITAGE, Matthew | Secrétaire | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | 193477020001 | |||||||
| DONALDSON, Euan James | Secrétaire | Woodburn Garvald EH41 4LN Haddington East Lothian | British | 41273760001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Secrétaire | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GREGORY, Mark Charles | Secrétaire | 1 Oaken Pin Close MK43 0DZ Cranfield Bedfordshire | British | 83675620002 | ||||||
| GREGORY, Robert William | Secrétaire | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | British | 109817750001 | ||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Secrétaire | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | British | 116752570004 | ||||||
| HIGGINS, Philip | Secrétaire | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | 262494640001 | |||||||
| MCCOLL, Mary Jean | Secrétaire | Keysoe Lodge Keysoe Row West MK44 2JF Keysoe Bedfordshire | British | 34757030001 | ||||||
| MELGES, Bethan | Secrétaire | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | 199705330001 | |||||||
| WALSH, Alistair Bruce | Secrétaire | 2 Copel Close Highfields Caldecote CB3 7ZQ Cambridge Cambridgeshire | British | 73803050001 | ||||||
| WILSON, Daniel Stewart | Secrétaire | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | 299160110001 | |||||||
| ANDERSON, John Bruce | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 29878320002 | |||||
| BAKER, Graham David | Administrateur | The Old Stables Warren Farm Barns Warren Lane MK45 4AS Clophill Bedforshire | British | 48564410002 | ||||||
| BARKE, Timothy John, Mr. | Administrateur | The Paddock Chapel End PE28 5TJ Sawtry Cambridgeshire | England | British | 295385930001 | |||||
| BRAND, Duncan Valentine | Administrateur | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 16800690001 | |||||
| BROOMFIELD, Matthew | Administrateur | 11 Centenary Road Brampton PE28 4YQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 108705890001 | ||||||
| BROWNE, Daniel Harry Rate | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 154494390001 | |||||
| COOPER, Sarah Jayne | Administrateur | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | United Kingdom | British | 188395230001 | |||||
| CREMIN, Theresa Bernadette | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 185269400001 | |||||
| DIXON, Kevin | Administrateur | 40 Fieldfare Way SG8 7XR Royston Hertfordshire | England | British | 41560840002 | |||||
| DIXON, Kevin | Administrateur | 14 Mallow Walk Studlands Rise SG8 9NF Royston Hertfordshire | British | 41560840001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Administrateur | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GORDON-STEWART, Alastair James | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 124512200002 | |||||
| GREGORY, Robert William | Administrateur | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| GREGORY, Robert William | Administrateur | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| HODGETTS, John Graham | Administrateur | 15 St Georges Close Brampton PE28 4US Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 111290960001 | |||||
| HOLDOM, Denise Ivy | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Lysander House Bedfordshire United Kingdom | England | British | 116935560002 | |||||
| HOMER, David | Administrateur | 28 Eastwood Drive Highwoods CO4 4EB Colchester Essex | British | 16658920001 | ||||||
| JACOB, Gareth Russell | Administrateur | Central Boulevard Shirley B90 8AU Solihull Tungsten Building England | United Kingdom | British | 303523150001 | |||||
| KING, Christopher | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 81798580013 | |||||
| LAWSON, Ian Michael | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 119365330001 | |||||
| MILLER, Keith Manson | Administrateur | Cherry Hollows 1(B)Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 546650002 | |||||
| MITCHELL, Ian John | Administrateur | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | England | British | 69476660001 | |||||
| MOORE, Nicholas Charles | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British | 277811200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twigden Homes Limited | 06 avr. 2016 | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0