CARPHONES OF EUROPE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CARPHONES OF EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03153320 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CARPHONES OF EUROPE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CARPHONES OF EUROPE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour CARPHONES OF EUROPE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Nomination de Joanne Sarah Finch en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Richard Wolfgang Henry Schäfer en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Allen en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Nowak en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Martin John Purkess le 01 juil. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Statuts | 28 pages | MA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Thomas Nowak le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christian Philip Quentin Allen le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Purkess le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CARPHONES OF EUROPE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIGHT, Garth Howard | Secrétaire | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire England | British | 130769810001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| PURKESS, Martin John | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 139360020001 | |||||
| SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158146600001 | |||||
| DUDGEON, James Alexander | Secrétaire | 7b Holland Park Avenue W11 3RH London | British | 46460760003 | ||||||
| EMETULU, Lola | Secrétaire | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||
| JEFFERSON, Karen | Secrétaire | 8 Bailey Close SN9 5HU Pewsey Wiltshire | British | 79393480001 | ||||||
| LAVER, John Michael | Secrétaire | Brook House Homestead Road TN8 6JD Edenbridge Kent | British | 8207040001 | ||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Secrétaire | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 123612980001 | ||||||
| BREWER, Stephen | Administrateur | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Administrateur | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| CHESWORTH, Paul | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| EDWARDS, Peter David | Administrateur | Hockets Oriental Road SL5 7AZ Sunninghill Berkshire | British | 1908570001 | ||||||
| EVANS, Mark | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| FORWORD, Jeremy David | Administrateur | The Lyons Stable Benham Chase Stockcross RG20 8LQ Newbury Berkshire | South Africa | 68480170001 | ||||||
| FREEMAN, William Ian Bede | Administrateur | Herons Cottage Ferry Lane, Medmenham SL7 2EZ Marlow Buckinghamshire | England | British | 64442870001 | |||||
| JAMES, Susan Louise | Administrateur | Flat 1d St Quintin Gardens W10 6AS London | British | 59878170001 | ||||||
| KEY, Matthew David | Administrateur | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 62981720001 | ||||||
| LANGSTON, Edward | Administrateur | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LANGSTON, Edward | Administrateur | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Administrateur | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| NEWLAND, David John | Administrateur | Patience House Inkpen Road RG17 9UA Kintbury Berkshire | England | British | 93566140001 | |||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| PAYNE, Philip Ian | Administrateur | Newmarket Cottage 5 Southbank Gardens Lambourn RG17 7LW Hungerford Berkshire | British | 64298440003 | ||||||
| READ, Nicholas Jonathan | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| SHERWOOD, Timothy Robin | Administrateur | Berry Oaks 12 Woodlands Avenue RG41 3HL Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 104309090001 | |||||
| TOURNON, Emanuele | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | 103542080002 | |||||
| TOWNSEND, John Raymond | Administrateur | Knowle House Chapel Corner Hamstead Marshall RG20 0HP Newbury Berkshire | British | 95223480001 | ||||||
| WARD, Alan Graham | Administrateur | 7 Dale Close Littleton SO22 6RA Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 65860450001 | |||||
| WEBB, Denys William | Administrateur | Oakfield Stud Whitemoor Lane, Upper Basildon RG8 8SF Reading Berkshire | United Kingdom | British | 76074580001 | |||||
| WHITTLE, John Richard | Administrateur | 54 Stirling Road BH3 7JH Bournemouth Dorset | British | 69660920001 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0