ZOOMPHASE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéZOOMPHASE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03154813
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ZOOMPHASE LIMITED ?

    • fabrication d'autres vêtements et accessoires n.c.a. (14190) / Industries manufacturières

    Où se situe ZOOMPHASE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10/14 Accommodation Road
    NW11 8ED London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ZOOMPHASE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JENNY PACKHAM (LONDON) LIMITED26 févr. 199626 févr. 1996
    PRYNTDESIGN LIMITED02 févr. 199602 févr. 1996

    Quels sont les derniers comptes de ZOOMPHASE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ZOOMPHASE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2012

    État du capital au 09 févr. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2010

    7 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Changement d'adresse du siège social de Unit a Spectrum House 32-34 Gordon House Road London NW5 1LP le 07 avr. 2011

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    5 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jennifer Packham le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mathew John Anderson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2009

    7 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2007

    7 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2006

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ZOOMPHASE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANDERSON, Mark David
    7 Avon Close
    St. George
    BS5 8DE Bristol
    Secrétaire
    7 Avon Close
    St. George
    BS5 8DE Bristol
    British46713690002
    ANDERSON, Mathew John
    Heath Hurst Road
    South End Green
    NW3 2RU London
    11
    United Kingdom
    Administrateur
    Heath Hurst Road
    South End Green
    NW3 2RU London
    11
    United Kingdom
    United KingdomBritish46837350004
    PACKHAM, Jennifer
    Heath Hurst Road
    South End Green
    NW3 2RU London
    11
    United Kingdom
    Administrateur
    Heath Hurst Road
    South End Green
    NW3 2RU London
    11
    United Kingdom
    United KingdomBritish48271520004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ZOOMPHASE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 févr. 2011
    Livré le 17 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Purchase merchant trading agreement/bill of exchange version trade finance agreement link
    Créé le 24 sept. 2009
    Livré le 24 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All goods financed by "raphaels bank" and documents representing such goods either by way of purchase/sale sale only or purchase only see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • R Raphael & Son PLC T/a "Raphaels Bank"
    Transactions
    • 24 sept. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed
    Créé le 24 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The companys equitable interest in the sum of £7,500 and any other sums paid into that account.
    Personnes ayant droit
    • Grosvenor Estate Belgravia
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 juin 2004
    Livré le 10 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit account and all money from time to time withdrawn from deposit account in accordance with the deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Ronald Michael Harris and Malcolm Webber
    Transactions
    • 10 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    All assets charge
    Créé le 12 janv. 1998
    Livré le 21 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a material purchase agreement and an accelerated payment trading agreement both of even date herewith
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Versailles Trade Finance Limited
    Transactions
    • 21 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets charge
    Créé le 12 janv. 1998
    Livré le 21 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a material purchase agreement and an accelerated payment trading agreement both of even date herewith
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Versailles Trade Finance Limited
    Transactions
    • 21 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 mai 1997
    Livré le 04 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0