PSP DIGITAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PSP DIGITAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03156669 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PSP DIGITAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | . Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PSP DIGITAL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour PSP DIGITAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul John Horton en tant que directeur le 24 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Anne Malyszko en tant qu'administrateur le 17 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Richard Tiszali en tant que directeur le 17 avr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr William Richard Tiszali en tant qu'administrateur le 08 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Brian Edward Anderson en tant qu'administrateur le 08 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alec Thomas Lappe en tant qu'administrateur le 08 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 févr. 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 031566690003 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 031566690004 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 031566690004, créée le 26 août 2016 | 50 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul John Horton en tant qu'administrateur le 29 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jacqueline Mary Marsh en tant que directeur le 02 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Guy Frederick St John Eaton en tant que directeur le 18 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Jacqueline Mary Marsh en tant qu'administrateur le 18 mai 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy Banks en tant qu'administrateur le 18 mai 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PSP DIGITAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON, Brian Edward | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 243492750001 | |||||
| BANKS, Timothy | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United Kingdom | British | 177269610001 | |||||
| LAPPE, Alec Thomas | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 243493380001 | |||||
| MALYSZKO, Anne La Belle | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 245454670001 | |||||
| EELES, Eric John, Doctor | Secrétaire | 23 Mutton Oaks Binfield RG12 8LZ Bracknell Berkshire | British | 19130790002 | ||||||
| HIGGINS, Steven Jeremy | Secrétaire | 17 Queens Road RG14 7NH Newbury Berkshire | British | 46764870001 | ||||||
| PROUDLOCK, Nicola Marie | Secrétaire | Garden Cottage West Meon GU32 1JL Petersfield Hampshire | British | 88234480003 | ||||||
| SPROXTON, Peter James | Secrétaire | 14 The Moors RG8 7LP Pangbourne Berkshire | British | 100088330001 | ||||||
| FORUM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 42 Cricklade Street SN1 3HD Swindon Wiltshire | 900005660001 | |||||||
| COOPER, Ian Graham | Administrateur | Bunces Lane RG8 7RH Collins End Westholme Barn United Kingdom | United Kingdom | British | 186068780001 | |||||
| CROSS, Howard John | Administrateur | Old Postings North Street GU31 5HG Rogate West Sussex | British | 78376040003 | ||||||
| CROSS, Ray John | Administrateur | Wormsley HR4 8LU Hereford Deerhaven United Kingdom | United Kingdom | British | 186071160001 | |||||
| DERRY, Simon John | Administrateur | Trevona Ashtead Woods Road KT21 2EX Ashtead Surrey | England | British | 89703280001 | |||||
| EATON, Guy Frederick St John | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | England | British | 150889170002 | |||||
| EELES, Eric John, Doctor | Administrateur | 23 Mutton Oaks Binfield RG12 8LZ Bracknell Berkshire | British | 19130790002 | ||||||
| FREDERICKS, Peter George | Administrateur | Danehill Lower Earley RG6 4PB Reading Hartman House Berkshire England | England | British | 95853260003 | |||||
| HIGGINS, Steven Jeremy | Administrateur | 17 Queens Road RG14 7NH Newbury Berkshire | British | 46764870001 | ||||||
| HORTON, Paul John | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United Kingdom | British | 169898500001 | |||||
| MARSH, Jacqueline Mary | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | England | British | 198956590001 | |||||
| MULLIGAN, Martin | Administrateur | Wadham Close Southrop GL7 3NR Lechlade 3 United Kingdom | England | British | 66989250001 | |||||
| PHILLIPS, Timothy John | Administrateur | 47 St Cross Road SO23 9PS Winchester Hampshire | British | 52480350002 | ||||||
| PITMAN, Graham Michael | Administrateur | Chiltern Cottage Christmas Common OX49 5HL Watlington Oxon | England | British | 13368750002 | |||||
| SMITH, Peter | Administrateur | 248 Benham Hill RG18 3AH Thatcham Berkshire | England | British | 89703240001 | |||||
| SMITH, Peter | Administrateur | 1 Abbey Wells Trade Street RG20 9UW Walton Hill Hampshire | British | 46764790002 | ||||||
| SPROXTON, Peter James | Administrateur | 14 The Moors RG8 7LP Pangbourne Berkshire | England | British | 100088330001 | |||||
| TISZALI, William Richard | Administrateur | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 243492790001 | |||||
| FORUM DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 42 Cricklade Street SN1 3HD Swindon Wiltshire | 900005650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PSP DIGITAL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snell Advanced Media Limited | 06 avr. 2016 | Turnpike Road RG14 2NX Newbury 31 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PSP DIGITAL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 26 août 2016 Livré le 05 sept. 2016 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 11 mars 2014 Livré le 27 mars 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK262688. Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK222477. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 févr. 2009 Livré le 06 mars 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each borrower and each other obligor (including the chargor) to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 22 janv. 1998 Livré le 28 janv. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0