BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED

BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03156768
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SLATERSHELFCO 312 LIMITED08 févr. 199608 févr. 1996

    Quels sont les derniers comptes de BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT à C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB le 07 juin 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2016

    État du capital au 09 févr. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 févr. 2015

    État du capital au 12 févr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 févr. 2014

    État du capital au 20 févr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin James Crotty le 28 juin 2013

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Mr Kevin James Crotty en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Allan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* le 21 déc. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Robert Yates en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Malin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Iain Grant en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* le 10 mars 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Secrétaire
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    BritishCompany Director96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Secrétaire
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Secrétaire désigné
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant80043450001
    DUNN, Christopher Frank
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur désigné
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    British900005180001
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Administrateur
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant2582690002
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker48153170001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Administrateur désigné
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor30535590006

    BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    B2000 borrower security agreement
    Créé le 06 févr. 2007
    Livré le 20 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Transactions
    • 20 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 18 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership or otherwise or in any other manner whatsoever and also all monies and liabilities which shall for the time being be due or to become due from bruntwood estates limited and/or bruntwood 2000 first properties limited to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership and on any account or in any other manner whatsoever
    Brèves mentions
    The property being freehold property known as fanum house (now known as landmark house) station road cheadle hulme stockport greater manchester title number GM76157 leasehold property known as land being part of fanum house (now known as landmark house) title number GM682291 for further details of the property please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transactions
    • 18 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of supplemental charge
    Créé le 02 févr. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    (A) all monies and liabilties due or to become due from the company to lloyds tsb bank PLC, capital markets (the "agent") and/or the banks and each of them on any account whatsoever and (b) the third party liabilities (as defined)
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage l/h land k/a north tower (formerly k/a highland house) victoria bridge street and 19 chapel street salford greater manchester. By way of first fixed charge all plant machinery implements building materials furniture and equipment; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 sept. 1996
    Livré le 30 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a credit agreement dated 20/9/96 and the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 30 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 1996
    Livré le 13 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fanum house station road cheadle hulme greater manchester t/no GM676157 and GM682291 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 1996
    Livré le 06 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £262,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge
    Brèves mentions
    Fanum house, station road, cheadle hume, greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • The Automobile Association Limited
    Transactions
    • 06 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mai 1996
    Livré le 04 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0