BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03156768 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o BRUNTWOOD LIMITED York House York Street M2 3BB Manchester England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT à C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB le 07 juin 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin James Crotty le 28 juin 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kevin James Crotty en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Allan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* le 21 déc. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Yates en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Malin en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Iain Grant en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009 | 5 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* le 10 mars 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKES, Katharine Jane | Secrétaire | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | British | Company Director | 96739300002 | |||||
CROTTY, Kevin James | Administrateur | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | England | British | Chartered Accountant | 117797270004 | ||||
OGLESBY, Christopher George | Administrateur | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 53530470002 | ||||
OGLESBY, Michael John | Administrateur | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 148307320001 | ||||
GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Secrétaire | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | British | 2582690002 | ||||||
ORRELL, Jeremy Peter | Secrétaire désigné | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
ALLAN, Andrew John | Administrateur | c/o Bruntwood Limited Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 80043450001 | ||||
DUNN, Christopher Frank | Administrateur désigné | 4 Ashcroft Close SK9 1RB Wilmslow Cheshire | British | 900005180001 | ||||||
GRANT, Iain James | Administrateur | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 45918940003 | ||||
GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Administrateur | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 2582690002 | ||||
MALIN, Richard William | Administrateur | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 48153170001 | ||||
OGLESBY, Jean Davies | Administrateur | Moss Farm Southdowns Road Bowdon WA14 3DR Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 29553390001 | ||||
ORRELL, Jeremy Peter | Administrateur désigné | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
YATES, Robert David | Administrateur | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 30535590006 |
BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
B2000 borrower security agreement | Créé le 06 févr. 2007 Livré le 20 févr. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 déc. 2001 Livré le 18 déc. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership or otherwise or in any other manner whatsoever and also all monies and liabilities which shall for the time being be due or to become due from bruntwood estates limited and/or bruntwood 2000 first properties limited to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership and on any account or in any other manner whatsoever | |
Brèves mentions The property being freehold property known as fanum house (now known as landmark house) station road cheadle hulme stockport greater manchester title number GM76157 leasehold property known as land being part of fanum house (now known as landmark house) title number GM682291 for further details of the property please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of supplemental charge | Créé le 02 févr. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti (A) all monies and liabilties due or to become due from the company to lloyds tsb bank PLC, capital markets (the "agent") and/or the banks and each of them on any account whatsoever and (b) the third party liabilities (as defined) | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage l/h land k/a north tower (formerly k/a highland house) victoria bridge street and 19 chapel street salford greater manchester. By way of first fixed charge all plant machinery implements building materials furniture and equipment; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 sept. 1996 Livré le 30 sept. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a credit agreement dated 20/9/96 and the finance documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 mai 1996 Livré le 13 juin 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fanum house station road cheadle hulme greater manchester t/no GM676157 and GM682291 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 mai 1996 Livré le 06 juin 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti £262,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge | |
Brèves mentions Fanum house, station road, cheadle hume, greater manchester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 mai 1996 Livré le 04 juin 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0