CODEMASTERS GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCODEMASTERS GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03158832
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CODEMASTERS GROUP LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe CODEMASTERS GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CODEMASTERS GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DEGREEBASIC LIMITED14 févr. 199614 févr. 1996

    Quels sont les derniers comptes de CODEMASTERS GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CODEMASTERS GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Cessation de la nomination de Rashid Ismail Varachia en tant que directeur le 30 juil. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Frank Theodore Sagnier en tant que directeur le 30 juil. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rashid Varachia en tant que secrétaire le 30 juil. 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Derek Wai Seng Chan en tant qu'administrateur le 30 juil. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Carlos Calonge en tant qu'administrateur le 30 juil. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Matthew Charles Stewart Webster en tant qu'administrateur le 30 juil. 2021

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam Warwickshire CV47 2DL à 30 Finsbury Square London EC2A 1AG le 12 avr. 2021

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 mars 2021

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2019 au 29 juin 2019

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2019 au 30 juin 2019

    3 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    18 pagesAA

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CODEMASTERS GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALONGE, Carlos Brian
    Onslow Street
    GU1 4TN Guildford
    Onslow House
    England
    Administrateur
    Onslow Street
    GU1 4TN Guildford
    Onslow House
    England
    United StatesAmericanBusiness Executive285961520001
    CHAN, Derek Wai Seng
    Onslow Street
    GU1 4TN Guildford
    Onslow House
    England
    Administrateur
    Onslow Street
    GU1 4TN Guildford
    Onslow House
    England
    EnglandCanadianFinancial Director231610330002
    WEBSTER, Matthew Charles Stewart
    Onslow Street
    GU1 4TN Guildford
    Onslow House
    England
    Administrateur
    Onslow Street
    GU1 4TN Guildford
    Onslow House
    England
    United KingdomBritishVp & Gm, Criterion & Ghost Games263289570001
    BAYNES, David Graham
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director177146390001
    DARLING, David
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    Secrétaire
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    BritishChairman25295440008
    DARLING, James Raymond
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector19392220001
    MARTIN, Paul Santo
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Secrétaire
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    154572030001
    PARSONS, Simon Lawrence
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Secrétaire
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    BritishChief Finance Officer161173620001
    STOCKTON, Neil David
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Secrétaire
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    172872090001
    VARACHIA, Rashid
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    175102600001
    WILSON, David John
    Benesque 214 Bramhall Moor Lane
    Hazel Grove
    SK7 5JJ Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    Benesque 214 Bramhall Moor Lane
    Hazel Grove
    SK7 5JJ Stockport
    Cheshire
    BritishDirector10851370002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAYNES, David Graham
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    Administrateur
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishFinancial Director177146390001
    COUSENS, Rodney Peter
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Administrateur
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    United KingdomBritishCeo42266870001
    DARLING, David
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector25295440008
    DARLING, James Raymond
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector19392220001
    DARLING, Richard
    The Paddock
    Long Itchington Road Offchurch
    CV33 9AT Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    The Paddock
    Long Itchington Road Offchurch
    CV33 9AT Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishCreative Director101317930001
    DEERING, Christopher Paul
    First Floor
    38 Lennox Gardens
    SW1X 0DH London
    Administrateur
    First Floor
    38 Lennox Gardens
    SW1X 0DH London
    United KingdomAmericanNon Exec Chairman123858760001
    DUNN, Gary Stuart
    26 The Peacocks
    CV34 6BS Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    26 The Peacocks
    CV34 6BS Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishDevelopment Manager93269150001
    GOSBELL, Sarah
    Stone Pit Meadow
    CV37 9WA Wilmcote
    Warwickshire
    Administrateur
    Stone Pit Meadow
    CV37 9WA Wilmcote
    Warwickshire
    BritishFinance Director77544170002
    HAYES, Michael
    269 Myton Road
    CV34 6PT Warwick
    Administrateur
    269 Myton Road
    CV34 6PT Warwick
    United KingdomBritishSales & Marketing97359980001
    HEMINGWAY, John
    23 Merestone Close
    CV47 1GU Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    23 Merestone Close
    CV47 1GU Southam
    Warwickshire
    BritishDevelopment Director71287490001
    JOHNSTON, Ken
    Weedon Cottage
    23 Weedon Lane
    HP6 5QT Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Weedon Cottage
    23 Weedon Lane
    HP6 5QT Amersham
    Buckinghamshire
    BritishMarketing Director98752150001
    KREIZ, Ynon
    Upper Masionette 4 Chalcot Road
    NW1 8LH London
    Administrateur
    Upper Masionette 4 Chalcot Road
    NW1 8LH London
    IsraeliDirector104680440001
    LAWTHER, William Michael
    Crabtree Cottage
    Leamington Road
    CV47 9PU Long Itchington
    Warwickshire
    Administrateur
    Crabtree Cottage
    Leamington Road
    CV47 9PU Long Itchington
    Warwickshire
    BritishFinance Director78490730003
    PARSONS, Simon Lawrence
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Administrateur
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    EnglandBritishChief Finance Officer161173620001
    PRICE, Anthony John
    133 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Administrateur
    133 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    United KingdomBritishCommercial Director107892990001
    RALLEY, Neil Alan
    Homebank
    The Lane, Hempton
    OX15 0QX Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Homebank
    The Lane, Hempton
    OX15 0QX Banbury
    Oxfordshire
    BritishSales Director80718770001
    SAGNIER, Frank Theodore
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritishChief Executive Officer196390590001
    VAN HAMEL-PARSON, Andrew Jonathan
    Christmas House
    Ledwell
    OX7 7AN Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Christmas House
    Ledwell
    OX7 7AN Chipping Norton
    Oxfordshire
    BritishDevelopment Director67499620001
    VARACHIA, Rashid
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritishCfo170342880001
    WHEELWRIGHT, Nicholas Charles
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    BritishManaging Director37082630007
    WILLIAMS, Anthony Ronald
    17 Burlington Street
    BA1 2SB Bath
    Avon & Somerset
    Administrateur
    17 Burlington Street
    BA1 2SB Bath
    Avon & Somerset
    EnglandBritishChief Operating Officer72612720001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CODEMASTERS GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Codemasters Holdings Limited
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Codemasters Campus
    Warwickshire
    England
    06 avr. 2016
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Codemasters Campus
    Warwickshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementWales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies For England & Wales
    Numéro d'enregistrement6123100
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CODEMASTERS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 28 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all that land and buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery from time to time under title number SY773291 being l/h land known as westbury house, 15 bury street, guildford see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Export Import Bank of India
    Transactions
    • 28 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 juil. 2012
    Livré le 21 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Export-Import Bank of India
    Transactions
    • 21 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 02 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Reliance Big Entertainment Pvt LTD
    Transactions
    • 02 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Amended and restated debenture
    Créé le 29 sept. 2009
    Livré le 06 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) Sarl
    Transactions
    • 06 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 mai 2009
    Livré le 01 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee and each charging company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) Sarl
    Transactions
    • 01 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A share pledge
    Créé le 25 juin 2007
    Livré le 16 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares being 500 shares of 300 euro par value each representing 100% of the share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P.
    Transactions
    • 16 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge executed outside the united kingdom over property situated there
    Créé le 15 juin 2007
    Livré le 09 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledged shares of eur 25,000.00. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. (The Facility Agent)
    Transactions
    • 09 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 15 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Interest in the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. (The Security Agent)
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession to a security agreement
    Créé le 24 mai 2007
    Livré le 12 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Facilityagent)
    Transactions
    • 12 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2007
    Livré le 08 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery including the properties registered under t/nos. WK304172, WK299681 and WK396247. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Venture Partners Iii (Luxembourg) S.A.R.L.
    Transactions
    • 08 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 mars 2002
    Livré le 19 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 nov. 2000
    Livré le 08 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under bonds guarantee indemnities documentary or other credits or any instruments
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Sa-Nv UK Branch
    Transactions
    • 08 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 oct. 2000
    Livré le 12 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CODEMASTERS GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 mars 2021Commencement of winding up
    24 juin 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0