M.I.F.T. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM.I.F.T. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03163536
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M.I.F.T. LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe M.I.F.T. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 8 Manchester International
    Freight Terminal World Freight
    M17 1DY Centre Europa Gate
    Trafford Park Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de M.I.F.T. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FREIGHT ESTATES LIMITED27 mars 199627 mars 1996
    COMPDALE SYSTEMS LIMITED23 févr. 199623 févr. 1996

    Quels sont les derniers comptes de M.I.F.T. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour M.I.F.T. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 févr. 2012

    État du capital au 21 févr. 2012

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Brian Richard Rosier en tant que directeur le 20 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael William Backs en tant que directeur le 20 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr George Richard Lines le 07 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael William Backs le 01 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Dalton Stephenson le 07 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages395

    legacy

    6 pages395

    Qui sont les dirigeants de M.I.F.T. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PRENTICE, David Drummond
    4 St Clare Road
    Lexden
    CO3 3SZ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    4 St Clare Road
    Lexden
    CO3 3SZ Colchester
    Essex
    British88464080001
    LINES, George Richard
    West Midlands Freight Terminal
    Station Road, Coleshill
    B46 1DT Birmingham
    Davies Turner Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    West Midlands Freight Terminal
    Station Road, Coleshill
    B46 1DT Birmingham
    Davies Turner Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Director18121770001
    STEPHENSON, Philip Dalton
    West Midlands Freight Terminal
    Station Road, Coleshill
    B46 1DT Birmingham
    Davies Turner Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    West Midlands Freight Terminal
    Station Road, Coleshill
    B46 1DT Birmingham
    Davies Turner Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritishFreight Forwarder11818580002
    MASTERS, John
    20 Upper Ground
    SE1 9LH London
    Secrétaire
    20 Upper Ground
    SE1 9LH London
    British46974580004
    WILLIAMSON, Ian Gordon Mcpherson
    4 Heathfield
    KT11 2QY Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    4 Heathfield
    KT11 2QY Cobham
    Surrey
    BritishChartered Accountant45964640001
    ALPHA SECRETARIAL LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Secrétaire désigné
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900004510001
    ANNFIELD, Alastair Graeme
    124 Westbourne Terrace Mews
    W2 6QG London
    Administrateur
    124 Westbourne Terrace Mews
    W2 6QG London
    BritishManaging Director44544290001
    BACKS, Michael William
    14 West Hayes
    CM22 7DH Hatfield Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 West Hayes
    CM22 7DH Hatfield Heath
    Hertfordshire
    United KingdomCanadianCompany Director40076560002
    CLARK, Colin
    20 Upper Ground
    SE1 9LH London
    Administrateur
    20 Upper Ground
    SE1 9LH London
    BritishSolicitor58534360001
    PRENTICE, David Drummond
    4 St Clare Road
    Lexden
    CO3 3SZ Colchester
    Essex
    Administrateur
    4 St Clare Road
    Lexden
    CO3 3SZ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishChartered Accountant88464080001
    ROSIER, Brian Richard
    CM23 1JH Bishop's Stortford
    Hadham Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    CM23 1JH Bishop's Stortford
    Hadham Park
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director133170050001
    UTTING, John Christopher
    353 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    Administrateur
    353 London Road
    CT14 9PS Deal
    Kent
    United KingdomBritishDirector5502320001
    WILLIAMSON, Ian Gordon Mcpherson
    4 Heathfield
    KT11 2QY Cobham
    Surrey
    Administrateur
    4 Heathfield
    KT11 2QY Cobham
    Surrey
    BritishChartered Accountant45964640001
    ALPHA DIRECT LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Administrateur désigné
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900001400001

    M.I.F.T. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge and release over current account
    Créé le 07 août 2006
    Livré le 10 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge the sums from time to time standing to the credit of an account with account number 4188220. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 10 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 août 2006
    Livré le 10 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H and l/h property land on south east side of bridgewater canal and lying to the north west of railway road thornbury road stretford t/n LA353280 and LA349644. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 10 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 nov. 2004
    Livré le 01 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 sept. 1996
    Livré le 04 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 sept. 1996
    Livré le 04 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H manchester international freight terminal trafford park manchester t/no LA349644 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 juin 1996
    Livré le 07 juin 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with a loan agreement dated 22ND may 1996
    Brèves mentions
    L/H land being manchester international freight terminal westinghouse road manchester t/no LA349644 with all buildibgs and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davies Turner & Co. Limited
    Transactions
    • 07 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 05 juin 1996
    Livré le 07 juin 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with a loan agreement dated 22ND may 1996
    Brèves mentions
    L/H land being manchester international freight terminal westinghouse road manchester t/no LA349644 with buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mat Group Limited
    Transactions
    • 07 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 22 mai 1996
    Livré le 24 mai 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a loan agreement of even date not exceeding £2,000,000 and this debenture
    Brèves mentions
    The l/h land being manchester international freight terminal westinghouse road manchester t/no LA349644. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davies Turner & Co. Limited
    Transactions
    • 24 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 22 mai 1996
    Livré le 24 mai 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a loan agreement of even date not exceeding £2,000,000 and this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mat Group Limited
    Transactions
    • 24 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0