ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED

ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03167586
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX à 1 More London Place London SE1 2AF le 08 nov. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 oct. 2017

    LRESSP

    État du capital au 02 oct. 2017

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Modification des détails de Odeon Cinemas Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mr John Brooks Rainer en tant qu'administrateur le 28 juin 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Stephen Alker en tant que directeur le 06 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert a Seefeldt en tant qu'administrateur le 12 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kirsten Lawton en tant que secrétaire le 12 juil. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Neil James Williams en tant que directeur le 06 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Jonathan Way en tant que directeur le 06 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Michael Donovan en tant que directeur le 30 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAINER, John Brooks
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United StatesAmerican235474660001
    SEEFELDT, Robert A
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United StatesAmerican235375430001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    British124301460001
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Secrétaire
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    British99741450001
    LAWTON, Kirsten
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Secrétaire
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    British50045660003
    MOORE, Gordon James
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Secrétaire
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    British64281120002
    STANESBY, Robert Edward Joseph
    29 Malvern Road
    SS5 5HZ Hockley
    Essex
    Secrétaire
    29 Malvern Road
    SS5 5HZ Hockley
    Essex
    British30171120001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    8th Floor Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HP London
    Secrétaire
    8th Floor Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HP London
    32444890001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    ALKER, Andrew Stephen
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Administrateur
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritish120642230001
    ARNOLD, Gary Kenneth
    8 The Wirrals
    ME5 0NT Chatham
    Kent
    Administrateur
    8 The Wirrals
    ME5 0NT Chatham
    Kent
    British89207860001
    CHADD, Andrew Peter
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    Administrateur
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    United KingdomBritish133578890002
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Administrateur
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    British52294450003
    DONOVAN, Paul Michael
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritish154988050002
    GARNER, Patrick Francis
    The Old Quarry
    Foxburrow Hill Road Bramley
    GU5 0BU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Old Quarry
    Foxburrow Hill Road Bramley
    GU5 0BU Guildford
    Surrey
    EnglandBritish157714260001
    GAVIN, Alexander Rupert
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Administrateur
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    EnglandBritish16875680005
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124301460001
    HANLON, Hugh Ronald Victor
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    Administrateur
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    British69843660001
    HARRIS, Roger John
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Administrateur
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish129109390001
    JENKINS, Barry Charles
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    Administrateur
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    EnglandBritish97730910001
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Administrateur
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    British99741450001
    KENISTON-COOPER, Graham James
    17 Ovington Square
    SW3 1LH London
    Administrateur
    17 Ovington Square
    SW3 1LH London
    EnglandBritish73698890002
    KEWARD, Barry James
    12 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    12 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    British96966030001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Administrateur
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    MASON, Jonathan Peter
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Administrateur
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish117783520001
    MCCANN, Alan Edward
    4 Tolsey Mead
    Borough Green
    TN15 8EH Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    4 Tolsey Mead
    Borough Green
    TN15 8EH Sevenoaks
    Kent
    British52154640001
    MOORE, Gordon James
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Administrateur
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    British64281120002
    O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    Administrateur
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    Irish89259830001
    PRIDAY, Stuart Richard
    72 Humphries Drive
    NN13 6PW Brackley
    Northamptonshire
    Administrateur
    72 Humphries Drive
    NN13 6PW Brackley
    Northamptonshire
    British89207570001
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Administrateur
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritish58870910002
    RITVAY, Alexander Tibor Mihaly, Dr
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    Administrateur
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    German95639320001
    RYMER, George Leslie
    17n Peabody Estate
    Wild Street
    WC2B 4BX London
    Administrateur
    17n Peabody Estate
    Wild Street
    WC2B 4BX London
    British47889810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Amc (Uk) Acquisitions Limited
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House 57-59 Haymarket
    England
    06 avr. 2016
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House 57-59 Haymarket
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement3878599
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture between (1) aceream limited (now known as odeon limited) (the parent) and others (as charging companies) and (2) merrill lynch international (as security agent)
    Créé le 19 févr. 2000
    Livré le 06 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due to the secured parties (as defined) (or any of them) by each charging company and each of the other obligors (as defined) (or any of them) under the senior finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch International as Security Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transactions
    • 06 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 02 mai 1996
    Livré le 17 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined therein) on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the financing documents (including this guarantee and debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 17 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ASSOCIATED BRITISH CINEMAS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 août 2018Dissolved on
    11 oct. 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0