M.T.K. CONTAINERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM.T.K. CONTAINERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03167857
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M.T.K. CONTAINERS LIMITED ?

    • (2821) /

    Où se situe M.T.K. CONTAINERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Rsm Robson Rhodes
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de M.T.K. CONTAINERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INFOMINI LIMITED05 mars 199605 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de M.T.K. CONTAINERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour M.T.K. CONTAINERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    legacy

    1 pages288b

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    legacy

    1 pages288b

    Déclaration des affaires en administration judiciaire suite au rapport aux créanciers

    16 pages3.3

    Déclaration des affaires en administration judiciaire suite au rapport aux créanciers

    10 pages3.3

    Rapport du séquestre administratif

    12 pages3.10

    Certificat modifié de constitution du comité des créanciers

    1 pages3.4

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages405(1)

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(353)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    10 pages395

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de M.T.K. CONTAINERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELL, Ian David
    83a Gilesgate
    DH1 1HY Durham
    County Durham
    Administrateur
    83a Gilesgate
    DH1 1HY Durham
    County Durham
    British70976410001
    WITTLIN, Felix Max, Doctor
    2 Chemin Biguex
    Chailly-Montreux
    Ch 1816
    Switzerland
    Administrateur
    2 Chemin Biguex
    Chailly-Montreux
    Ch 1816
    Switzerland
    Swiss72634360001
    AITKEN, David Andrew
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    British87190800001
    COLLINS, Michael David Gibson
    15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Buckinghamshire
    Secrétaire
    15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Buckinghamshire
    British60886260003
    COLLINS, Michael David Gibson
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60886260002
    DEAN, Stephen Donald Charles
    49 Cromford Road
    SW18 1PA London
    Secrétaire
    49 Cromford Road
    SW18 1PA London
    British67535290002
    NOAH, Frank Edward
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British27829510002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AITKEN, David Andrew
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    British87190800001
    BROMLEY-MARTIN, Robin Hampden
    Leisure Cottage
    Church Road
    GU29 0EH West Lavington
    Administrateur
    Leisure Cottage
    Church Road
    GU29 0EH West Lavington
    United KingdomBritish110319440001
    COLLINS, Michael David Gibson
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60886260002
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritish30827780001
    DAVIES, Andrew Owen Evan
    The Lawn Brent Hill
    ME13 7EF Faversham
    Kent
    Administrateur
    The Lawn Brent Hill
    ME13 7EF Faversham
    Kent
    British40795600002
    DEAKIN, Graham Ronald
    69 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    69 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British60807750001
    FISKE, Barry John
    8 Staitheway Road
    NR12 8TH Wroxham
    Norfolk
    Administrateur
    8 Staitheway Road
    NR12 8TH Wroxham
    Norfolk
    United KingdomBritish126228790001
    KUTLUOGLU, Mehmet Tayfun
    14 Parc Chateau Banquet
    1202 Geneva
    Switzerland
    Administrateur
    14 Parc Chateau Banquet
    1202 Geneva
    Switzerland
    Turkish51924640001
    KUTLUOGLU, Omer
    7 Broad Garth
    Blue Anchor Court
    NE1 3HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    7 Broad Garth
    Blue Anchor Court
    NE1 3HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British75656880001
    MORRIS, John
    Le Clos De La Brague
    Qtr Tamarins
    06410 Biot
    France
    Administrateur
    Le Clos De La Brague
    Qtr Tamarins
    06410 Biot
    France
    British52203280001
    NOAH, Frank Edward
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Administrateur
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British27829510002
    TASKENT, Turul
    57 Granville Court
    NE2 1TR Newcastle Upon Tyne
    North East
    Administrateur
    57 Granville Court
    NE2 1TR Newcastle Upon Tyne
    North East
    Turkish75656750001
    THOMAS, John Alan, Sir
    Highwood Park Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    Administrateur
    Highwood Park Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    United KingdomBritish10699990001
    WILKINSON, John
    7 Oakfield Close
    SR3 3RT Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    7 Oakfield Close
    SR3 3RT Sunderland
    Tyne & Wear
    British60807830001
    WINGFIELD, Andrew
    101 Broom Lane
    Whickham
    NE16 4PT Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Administrateur
    101 Broom Lane
    Whickham
    NE16 4PT Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish52203320001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    M.T.K. CONTAINERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Chattel mortgage
    Créé le 17 juil. 2001
    Livré le 21 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Various chattels as specified in schedule to form 395 relative to the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge over all stock
    Créé le 27 juin 2000
    Livré le 06 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement
    Brèves mentions
    All stock owned by the borrower including raw materials and components and work in progress partly finished and finished goods for specific stock tanks.
    Personnes ayant droit
    • North East Regional Investment Fund Limited
    Transactions
    • 06 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 30 juin 1998
    Livré le 30 juin 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One tursdale engineering access platform ref no 1084..one rocom tsc imagination telephone system ref no 970387..xbs computer equipment ref no 1216..for further details see schedule to form 395.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Group Limited
    Transactions
    • 30 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 27 mars 1998
    Livré le 30 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to the 395 as one vacublast international waffle floor blastroom ref no 131,383,1022 one anopol hydro station ref 786 one xbs deskpro 2000 pc ref 834. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Group Limited
    Transactions
    • 30 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 23 févr. 1998
    Livré le 23 févr. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One casanova hydraulic guillotine shear model vce-16 serial no.3942 Register no.97-p-001, one casanova hydraulic rolling machine model pcv-22/s serial no.3943 Register no:97-p-002, real time x-ray camera register no.97-p-061 for details of further chattels please see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Group Limited
    Transactions
    • 23 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 07 janv. 1998
    Livré le 08 janv. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Emi x ray cell and manipulators d/n SB373397 3 x dalby commercial vehicle spay booth/ovens s/n SB3733A97 for further details of equipment charged reger to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Group Limited
    Transactions
    • 08 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2002Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 25 janv. 2005Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
      • Numéro de dossier 1

    M.T.K. CONTAINERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 août 1997Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Charles William Anthony Escott
    Grant Thornton Uk Llp
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds West Yorkshire,
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds West Yorkshire,
    Michael John Hore
    Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London
    practitioner
    Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0