CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD

CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03167993
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD ?

    Adresse du siège social
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRYGONE PROPERTIES LTD16 déc. 200516 déc. 2005
    SMARTSENSE LIMITED02 avr. 199602 avr. 1996
    SMARTSCENE LIMITED05 mars 199605 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gary Ryan Fee le 27 août 2020

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Rosamund Margaret Marshall en tant qu'administrateur le 16 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Guy Casagrande en tant qu'administrateur le 16 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gary Ryan Fee en tant qu'administrateur le 16 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Walter Tugendhat en tant que directeur le 13 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dave Lissy en tant que directeur le 13 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Dreier en tant que directeur le 13 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 23 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr James Walter Tugendhat en tant qu'administrateur le 10 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2016

    État du capital au 27 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2015

    État du capital au 03 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Mary Ann Tocio en tant que directeur le 01 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2015

    État du capital au 01 avr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Qui sont les dirigeants de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    170449670001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican70853820001
    CASAGRANDE, John Guy
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican269010340001
    FEE, Gary Ryan
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United KingdomBritish269008830002
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    EnglandBritish269043470001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Secrétaire
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Secrétaire
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    British169843720001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Secrétaire désigné
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003990001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    BULL, Malcolm Richard
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    Administrateur
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    EnglandBritish10155680001
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Administrateur
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican170443250001
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LEWIS, David
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    British51773710002
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican218331690001
    MALCOLMSON, John Bryce
    10 Holyoak Crescent
    Horsell
    GU21 4PN Woking
    Surrey
    Administrateur
    10 Holyoak Crescent
    Horsell
    GU21 4PN Woking
    Surrey
    British51773690001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    TICE, Richard James Sunley
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish151240670006
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    UsaUsa177507090001
    TUGENDHAT, James Walter
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United KingdomBritish218306870001
    WHITLAM, Paul
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    British47737380001
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Administrateur désigné
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bright Horizons Family Solutions Limited
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    27 janv. 2017
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental debenture
    Créé le 12 mai 2011
    Livré le 20 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All it's right title interest and benefit in and to the land see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture
    Créé le 14 nov. 2008
    Livré le 18 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All it's right title interest and benefit in and to the land see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 mai 2008
    Livré le 20 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £36,000=00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The cash sum of £36,000.
    Personnes ayant droit
    • Classic Management Services Limited
    Transactions
    • 20 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental debenture
    Créé le 09 mai 2008
    Livré le 16 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H former garage premises grena road richmond surrey t/n TGL189133 and the security assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 10 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H inglewood farm sonning lane sonning t/no BK225651,f/h land adjoining inglewood house sonning lane sonning berkshire t/no BK309428 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 10 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture being supplemental to a debentured given on 21 december 2004 and
    Créé le 11 févr. 2008
    Livré le 13 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Strathmore house brighton road banstead t/n SY381533, high trees wokingham road rounds hill bracknell t/n BK159196, 1 cob close tassel road bury st edmunds t/n's SK251153 and SK284737, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 13 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture
    Créé le 04 déc. 2007
    Livré le 19 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property at academy day nursery gibson drive kings hill west malling (t/no K824499) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture
    Créé le 22 oct. 2007
    Livré le 26 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property owned by the mortgagor k/a merrow clinic 19 boxgrove lane merrow guildford t/no SY259691. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transactions
    • 26 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture
    Créé le 30 juin 2006
    Livré le 05 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property at stepping stones 105 penn hill avenue poole dorset t/no DT47303 and f/h property k/a moonacre potterne way verwood dorset t/no DT67285. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 05 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture
    Créé le 31 janv. 2006
    Livré le 08 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H shortlands united reform church 84-90 martins road bromley t/no SGL584373, f/h 48 sydenham road croydon t/no SGL615676 and f/h 83A belmont hill lewisham london t/no SGL193573.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 08 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security accession deed
    Créé le 06 juin 2005
    Livré le 16 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1) f/h property k/a the green, frimley green, surrey GU16 6HF, t/n SY105671, 2) f/h property k/a rushmoor independent school, 40 reading road, farnborough, t/n HP559226, 3) f/h property k/a hatton hill nursery, hatton hill, windlesham, surrey, t/n SY420855 and SY565088, see form 395 for other properties charged; and any interest in any other land, all shares and all related distribution rights;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transactions
    • 16 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Accession deed to intercreditor deed
    Créé le 06 juin 2005
    Livré le 16 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company agrees to become a party to and be bound by the intercreditor deed as an obligor, will upon demand by the security trustee pay an amount equal to the amount of all payments or distributions of or in respect of any junior liablities in cash or in kind;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transactions
    • 16 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 05 août 2003
    Livré le 09 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as nursery school site, rail road heath, fleet, hert, hampshire t/n HP613289. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 2002
    Livré le 17 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that freehold property known as farnborough day nursery formerly rushmore independent school 40 reading road farnborough rushmore hampshire title number HP559226. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 2002
    Livré le 17 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that leasehold property known as land and premises situate at and known as the old toll house and the new toll house sandown park surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 2002
    Livré le 17 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that freehold property known as hatton hill day nursery being the land and buildings on the south side of hatton hill windlesham surrey heath surrey title number SY420855 and all that freehold land laying to the south west of hatton hill windlesham surrey heath surrey title number SY565088. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 nov. 2002
    Livré le 17 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 2002
    Livré le 17 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that freehold property known as frimley green day nursery 1 the green frimley green surrey heath surrey GU16 6HF title number SY105671. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £310,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Freehold property k/a land at elvetham heath fleet hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 12 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £295,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    1 the green frimley green camberley surrey.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1998
    Livré le 11 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a rushmoor independent school comprising piece of land having a frontage of 80 feet to the north side of reading road farnborough. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 1998
    Livré le 07 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property at 22 crawley hill canberley t/no;-SY166415.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Ventures Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 juil. 1997
    Livré le 06 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Mylesdown 22 crawley hill camberley street surrey t/n sy 166415.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 juin 1996
    Livré le 24 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the southside of hatton hill windlesham and land lying to the south west ofhatton hill widlesham surrey t/no SY420855 & sy 565088.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 avr. 1996
    Livré le 01 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0