COMPLINET UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPLINET UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03170722
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPLINET UK LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe COMPLINET UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Five Canada Square
    Canary Wharf
    SE2 5AQ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMPLINET UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COMPLINET LIMITED08 mars 200108 mars 2001
    THE PERSONAL WEB COMPANY LIMITED29 août 199629 août 1996
    SPORTSWEB LIMITED11 mars 199611 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de COMPLINET UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPLINET UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01
    XA92MF6Y

    État du capital au 22 juin 2021

    • Capital: GBP 155.85
    3 pagesSH19
    AA6S0I63

    legacy

    1 pagesSH20
    AA6S0I5N

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    AA6S0I5F

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA56ZRKA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Kimberley Major le 04 déc. 2020

    2 pagesCH01
    X9ZI16JT

    legacy

    1 pagesSH20
    A9FULMFT

    État du capital au 27 oct. 2020

    • Capital: GBP 1,558.47
    3 pagesSH19
    A9FULMG9

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    A9FULMGH

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium and capital redemption reserve cancelled 02/10/2020
    RES13

    legacy

    1 pagesSH20
    A9F7M80H

    État du capital au 15 oct. 2020

    • Capital: GBP 1,558.47
    3 pagesSH19
    A9F7M81L

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    A9F7M80X

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c and cap redemption reserve 02/10/2020
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    5 pagesAA
    A9EN7SEH

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X95UTUYH

    Changement d'adresse du siège social de The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade Canary Wharf London E14 5EP United Kingdom à Five Canada Square Canary Wharf London SE2 5AQ le 14 févr. 2020

    1 pagesAD01
    X8YSWOCJ

    Nomination de Ms Barbara Abena Boateng en tant qu'administrateur le 28 juin 2019

    2 pagesAP01
    X8D0WH37

    Cessation de la nomination de Stuart Nicholas Corbin en tant que directeur le 28 juin 2019

    1 pagesTM01
    X8A8H85L

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA
    L87JPLHD

    Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X816XLCQ

    Qui sont les dirigeants de COMPLINET UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOATENG, Barbara Abena
    Canary Wharf
    SE2 5AQ London
    Five Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    SE2 5AQ London
    Five Canada Square
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary251982460001
    MAJOR, Kimberley
    Canary Wharf
    SE2 5AQ London
    Five Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    SE2 5AQ London
    Five Canada Square
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant250671310002
    JENNER, Susan Louise
    1 Mark Square
    Leonard Street
    EC2A 4EG London
    2nd Floor
    Secrétaire
    1 Mark Square
    Leonard Street
    EC2A 4EG London
    2nd Floor
    156884410002
    LEASON, James Henricus
    68 Upper Thames Street
    EC4V 3BJ London
    Vintners Place
    United Kingdom
    Secrétaire
    68 Upper Thames Street
    EC4V 3BJ London
    Vintners Place
    United Kingdom
    155885040001
    PATON, Daryl Marc
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    Secrétaire
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    British104564540001
    ROBERTS, Nicholas David Denby
    16 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    Secrétaire
    16 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    BritishCompany Director68663160001
    WIDDOWSON, Anthony Nigel
    14 Somerville House
    Manor Fields Putney Hill
    SW15 3LX London
    Secrétaire
    14 Somerville House
    Manor Fields Putney Hill
    SW15 3LX London
    BritishFinancial Director63759200002
    SEMKEN LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005970001
    BARRETT, Jenny Suzanne
    69 Stillingfleet Road
    Barnes
    SW13 9AF London
    Administrateur
    69 Stillingfleet Road
    Barnes
    SW13 9AF London
    BritishOperations Director77617330001
    CLARKE, Darryl John
    Floor
    Aldgate House 33 Aldgate High Street
    EC3N 1DL London
    2nd
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Aldgate House 33 Aldgate High Street
    EC3N 1DL London
    2nd
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant140709790001
    CORBIN, Stuart Nicholas
    30 South Colonnade
    Canary Wharf
    E14 5EP London
    The Thomson Reuters Building
    United Kingdom
    Administrateur
    30 South Colonnade
    Canary Wharf
    E14 5EP London
    The Thomson Reuters Building
    United Kingdom
    EnglandBritishInternational Treasurer86551230002
    CRAIG, David William Ian
    68 Upper Thames Street
    EC4V 3BJ London
    Complinet Offices 3rd Floor Vintners Place
    Administrateur
    68 Upper Thames Street
    EC4V 3BJ London
    Complinet Offices 3rd Floor Vintners Place
    United KingdomBritishCompany Director127939650001
    JENNER, Susan Louise
    1 Mark Square
    Leonard Street
    EC2A 4EG London
    2nd Floor
    Administrateur
    1 Mark Square
    Leonard Street
    EC2A 4EG London
    2nd Floor
    EnglandBritishCompany Secretary45156020002
    MCALEESE, Daniel
    9a Ashburnham Grove
    Greenwich
    SE10 8UH London
    Administrateur
    9a Ashburnham Grove
    Greenwich
    SE10 8UH London
    EnglandIrishHead Of Product Development75975470001
    MCNAIR SCOTT, David
    12 Tyrawley Road
    SW6 4QQ London
    Administrateur
    12 Tyrawley Road
    SW6 4QQ London
    United KingdomBritishAccountant120020990001
    MITCHLEY, David Martin
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1DL London
    2nd Floor Aldgate House
    United Kingdom
    Administrateur
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1DL London
    2nd Floor Aldgate House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant146369720001
    MORGAN, David Owen
    306 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9PY London
    Administrateur
    306 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9PY London
    United KingdomBritishCompany Director117309790001
    PATON, Daryl Marc
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant104564540001
    PATON, Daryl Marc
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    Administrateur
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    EnglandBritishAccountant104564540001
    PILLING, Christopher Charles
    Water Lane
    Enton
    GU8 5AG Godalming
    Burntwood House
    Surrey
    Administrateur
    Water Lane
    Enton
    GU8 5AG Godalming
    Burntwood House
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director141908080002
    PILLING, Christopher Charles
    Flat A 168 Osward Road
    Wandsworth
    SW17 7SS London
    Administrateur
    Flat A 168 Osward Road
    Wandsworth
    SW17 7SS London
    BritishCompany Director35865700004
    ROBERTS, Nicholas David Denby
    Clanalpine Street
    Mosman
    20
    2088
    Aus
    Administrateur
    Clanalpine Street
    Mosman
    20
    2088
    Aus
    BritishCommercial Director80118860007
    ROBERTS, Nicholas David Denby
    16 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    Administrateur
    16 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    BritishCompany Director68663160001
    SHAWKAT, Haydar Suham
    Avenue Road
    Swiss Cottage
    NW3 3PF London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    Avenue Road
    Swiss Cottage
    NW3 3PF London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant89797290001
    THOMPSON, Patrick Hugh
    Flat 5
    9 Prince Arthur Road Hampstead
    NW3 6AX London
    Administrateur
    Flat 5
    9 Prince Arthur Road Hampstead
    NW3 6AX London
    United KingdomBritishDirector Of Training79856980001
    THORN, Peter
    30 South Colonnade
    Canary Wharf
    E14 5EP London
    The Thomson Reuters Building
    United Kingdom
    Administrateur
    30 South Colonnade
    Canary Wharf
    E14 5EP London
    The Thomson Reuters Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant150009250002
    TIFFIN, Philip
    47 Mereway Road
    TW2 6RF Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    47 Mereway Road
    TW2 6RF Twickenham
    Middlesex
    BritishHr Director77617440001
    VIALL, Alex John
    The Oaks 2 Erica Close
    West End
    GU24 9PE Woking
    Surrey
    Administrateur
    The Oaks 2 Erica Close
    West End
    GU24 9PE Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director62674180001
    WIDDOWSON, Anthony Nigel
    14 Somerville House
    Manor Fields Putney Hill
    SW15 3LX London
    Administrateur
    14 Somerville House
    Manor Fields Putney Hill
    SW15 3LX London
    BritishFinancial Director63759200002
    LUFMER LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005960001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMPLINET UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AQ London
    Five
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AQ London
    Five
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1679046
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    COMPLINET UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit
    Créé le 30 juin 2010
    Livré le 06 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit being the sum or sums from time to time standing to the credit of the account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Vintners' Propco S.A.R.L.
    Transactions
    • 06 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security agreement
    Créé le 06 déc. 2007
    Livré le 21 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the office equipment furniture fixtures fittings computer equipment and plant and machinery (the equipment) assigns all rights title and interest in to under or arising out of all licences guarantees rents deposits contracts convents warranties agreements and arrangements, all policies of insurance and assurance relating to the equipment adn all proceeds thereof. By way of floating the undertaking and assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Noble Venture Finance I Limited
    Transactions
    • 21 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 06 déc. 2007
    Livré le 21 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the office equipment furniture fixtures fittings computer equipment and plant and machinery (the equipment) assigns all rights title and interest in to under or arising out of all licences guarantees rents deposits contracts convents warranties agreements and arrangements, all policies of insurance and assurance relating to the equipment adn all proceeds thereof. By way of floating the undertaking and assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Noble Venture Finance Ii Sa
    Transactions
    • 21 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 25 juin 2004
    Livré le 09 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 66036453.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 24 oct. 2001
    Livré le 30 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the undertaking goodwill assets rights revenues and property of the company whatsoever and wheresoever both present and future including all tangible and intangible assets and its uncalled capital for the time being and any landor buildings and any interest of the company therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 30 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent security deposit deed
    Créé le 26 févr. 2001
    Livré le 07 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brèves mentions
    £193,746 to be held in the deposit account with interest credited thereon.
    Personnes ayant droit
    • Getronics UK Limited
    Transactions
    • 07 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0