SRG REALISATIONS (2017) PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSRG REALISATIONS (2017) PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03170812
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SRG REALISATIONS (2017) PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SRG REALISATIONS (2017) PLC ?

    Adresse du siège social
    40 31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SRG REALISATIONS (2017) PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SECURITY RESEARCH GROUP PLC22 août 201222 août 2012
    PSG SOLUTIONS PLC14 févr. 200614 févr. 2006
    LONDON & BOSTON INVESTMENTS PLC 28 sept. 200128 sept. 2001
    CYBERTEC HOLDINGS PLC06 juin 199606 juin 1996
    MONEYADVANCE PUBLIC LIMITED COMPANY12 mars 199612 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de SRG REALISATIONS (2017) PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SRG REALISATIONS (2017) PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    18 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 juil. 2019

    20 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 juil. 2018

    22 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Distribution in specie/distribution to b shareholders 06/04/2018
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    55 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Certificat de changement de nom

    Company name changed security research group PLC\certificate issued on 15/08/17
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name15 août 2017

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2017 au 17 juil. 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 17 juil. 2017

    LRESSP

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2017

    33 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Vicarage House 58-60 Kensington Church Street London W8 4DB England à 40 31st Floor Bank Street London E14 5NR le 13 juil. 2017

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2017 avec mises à jour

    44 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2016

    33 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 31 mars 2016

    • Capital: GBP 3,961,812
    3 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2016 avec liste étendue des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 avr. 2016

    État du capital au 04 avr. 2016

    • Capital: GBP 3,929,589.6
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré The Registry Beckenham Road Beckenham Kent BR3 4TU

    1 pagesAD03

    État du capital après une attribution d'actions au 25 janv. 2016

    • Capital: GBP 3,929,589.6
    3 pagesSH01

    Nomination de Mr John Arthur Warwick en tant qu'administrateur le 23 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2015

    31 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 133 Ebury Street London SW1W 9QU à Vicarage House 58-60 Kensington Church Street London W8 4DB le 29 juin 2015

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de SRG REALISATIONS (2017) PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARWICK, John Arthur
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    Secrétaire
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    BritishDirector16010920003
    CONNOR, Bernard Cavan
    Willoughbridge
    TF9 4JJ Market Drayton
    Long Shoots
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Willoughbridge
    TF9 4JJ Market Drayton
    Long Shoots
    Shropshire
    England
    United KingdomBritishDirector120653840002
    MERVIS, Jonathan Philip
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    Administrateur
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    EnglandBritishDirector6534190005
    WARWICK, John Arthur
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    Administrateur
    31st Floor
    Bank Street
    E14 5NR London
    40
    England
    EnglandBritishChartered Accountant16010920003
    MAY, John Joseph
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant211557370001
    PHILLIPS, Anne Elizabeth
    Jasmine Dean
    Tunworth Road Mapledurwell
    RG25 2LU Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    Jasmine Dean
    Tunworth Road Mapledurwell
    RG25 2LU Basingstoke
    Hampshire
    British44735140001
    SELBY, David Frederick Mclaren
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    BritishFca Cd14775130001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Secrétaire
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Edward
    1st Floor 100 Belsize Lane
    Belsize Village
    NW3 5BB London
    Administrateur
    1st Floor 100 Belsize Lane
    Belsize Village
    NW3 5BB London
    BritishDirector74931040003
    BARTON, Christopher Synge
    Carpenters Cottage
    Compton Pauncefoot
    BA22 7EN Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    Carpenters Cottage
    Compton Pauncefoot
    BA22 7EN Yeovil
    Somerset
    United KingdomBritishChairman107260300001
    BROWN, Tweedie Mcgarth
    133 Ebury Street
    London
    SW1W 9QU
    Administrateur
    133 Ebury Street
    London
    SW1W 9QU
    EnglandBritishDirector154541620001
    BURLEY, John Martin
    Two The Dale
    DE4 4EJ Wirksworth
    Derbyshire
    Administrateur
    Two The Dale
    DE4 4EJ Wirksworth
    Derbyshire
    BritishCompany Director107621350001
    BURTON, Christopher John
    9 Gables Avenue
    WD6 4SP Borehamwood
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 Gables Avenue
    WD6 4SP Borehamwood
    Hertfordshire
    BritishAccountant2382240001
    COTGROVE, Peter Leonard George
    21 Cages Way Melton Park
    Woodbridge
    IP12 1TE Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    21 Cages Way Melton Park
    Woodbridge
    IP12 1TE Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishConsultant80666880001
    DART, Geoffrey Gilbert
    133 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    Administrateur
    133 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    AustralianDirector76453360006
    ELSTEIN, Jonathan Michael
    15a Fitzjohns Avenue
    NW3 5JY London
    Administrateur
    15a Fitzjohns Avenue
    NW3 5JY London
    EnglandBritishSolicitor70057160003
    HESTER, Julie Amanda
    1137 North Lakeshore Drive
    Sarasota
    34231 Usa Florida
    Usa
    Administrateur
    1137 North Lakeshore Drive
    Sarasota
    34231 Usa Florida
    Usa
    UsaBritishCompany Director99548840001
    HOLME, John David Gawain
    Hodders Wood
    40 Littleheath Lane
    KT11 2QN Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Hodders Wood
    40 Littleheath Lane
    KT11 2QN Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant110178190001
    KOMLOSY, Stephen Anton
    1 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector65257060002
    LISTER, Alan John
    Le Mont Saint
    Rue Du Hamel
    GY7 9XX St Saviour
    Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Le Mont Saint
    Rue Du Hamel
    GY7 9XX St Saviour
    Guernsey
    Channel Islands
    BritishCompany Director41671790001
    MAY, John Joseph
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant211557370001
    MITCHELL, Ian Robert
    Connybear Wood St Marychurch Road
    Coffinswell
    TQ12 4SE Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Connybear Wood St Marychurch Road
    Coffinswell
    TQ12 4SE Newton Abbot
    Devon
    United KingdomBritishDirector60444540001
    RAE, James William
    33 William Road
    BH7 7BB Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    33 William Road
    BH7 7BB Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishDirector68378600001
    SELBY, David Frederick Mclaren
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Hayward Green Farm
    West Woodhay
    RG20 0BJ Newbury
    Berkshire
    BritishFca14775130001
    SMALLWOOD, Malcolm Terry
    34 Long Barton
    Kingsteignton
    TQ12 3QP Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    34 Long Barton
    Kingsteignton
    TQ12 3QP Newton Abbot
    Devon
    BritishBusiness Manager56309470001
    WARWICK, John Arthur
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    Administrateur
    Flat 308 Peninsula Apartments
    4 Praed Street Paddington
    W2 1JE London
    EnglandBritishDirector16010920003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Administrateur
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    44503290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Administrateur désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SRG REALISATIONS (2017) PLC ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    12 mars 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    SRG REALISATIONS (2017) PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 janv. 2006
    Livré le 17 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Memorandum of deposit and charge
    Créé le 01 oct. 2004
    Livré le 15 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The stocks, shares, bonds, debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank being all marketable securities whilst in the possession of the bank which are now or may hereafter be deposited with the bank by the company or on behalf of the company.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 juin 2004
    Livré le 10 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 15 avr. 2004
    Livré le 28 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 17 févr. 2004
    Livré le 28 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 19 août 2003
    Livré le 28 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Details of charged account(s) barclays bank PLC re london & boston investments PLC business tracker account account number 10635413. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SRG REALISATIONS (2017) PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 juil. 2017Commencement of winding up
    07 mai 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Kirstie Jane Provan
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0