EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED

EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03170995
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sevendale House 3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLAGSHIP CARE (SURREY) LIMITED09 mai 199709 mai 1997
    BROOMCO (1051) LIMITED12 mars 199612 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ England à Sevendale House 3rd Floor, Suite 6C 5-7 Dale Street Manchester Greater Manchester M1 1JB le 06 nov. 2018

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Emma Margaret Clarke en tant que secrétaire le 16 oct. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Thomas Adams en tant que secrétaire le 16 oct. 2018

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 10-11 Welken House Charterhouse Square London EC1M 6EH England à 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ le 05 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr David Thomas Adams en tant que secrétaire le 12 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gordon Neil Springett en tant que secrétaire le 12 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Robert Alistair Martin Gillespie en tant qu'administrateur le 05 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jennifer Louise Crouch en tant que directeur le 05 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2016

    État du capital au 14 mars 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Richard Daniel Knight en tant que directeur le 01 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sion Laurence Jones en tant que directeur le 01 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Jennifer Louise Crouch en tant qu'administrateur le 01 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Philip Arthur Would en tant qu'administrateur le 01 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARKE, Emma Margaret
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Secrétaire
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    251514980001
    GILLESPIE, Robert Alistair Martin
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Administrateur
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish230652780001
    WOULD, Philip Arthur
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Administrateur
    3rd Floor, Suite 6c
    5-7 Dale Street
    M1 1JB Manchester
    Sevendale House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish157945610001
    ADAMS, David Thomas
    120 Aldersgate Street
    EC1A 4JQ London
    5th Floor
    England
    Secrétaire
    120 Aldersgate Street
    EC1A 4JQ London
    5th Floor
    England
    238967880001
    CROSSLEY, Hugh Barnabas
    Stonebridge House
    Wiveton
    NR25 7TP Holt
    Norfolk
    Secrétaire
    Stonebridge House
    Wiveton
    NR25 7TP Holt
    Norfolk
    British107284040001
    HANDLEY, David Michael
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    British52899270001
    PINNINGTON, Ian Harry
    Shillingford Bucklow View
    Bowdon
    WA14 3JP Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    Shillingford Bucklow View
    Bowdon
    WA14 3JP Altrincham
    Cheshire
    British11801040001
    SMITH, Jonathan Charles
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    British127121960001
    SPRINGETT, Gordon Neil
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Secrétaire
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    169292500001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    CHRITSTIE, Rory William
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o King Sturge Finance
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritish152827480001
    CROUCH, Jennifer Louise
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Administrateur
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    EnglandBritish199682550001
    HANDLEY, David Michael
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish52899270001
    HARRIS, John David
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Administrateur
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    EnglandBritish174333200001
    JACKSON, Geoffrey Allan
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Administrateur
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    United KingdomBritish79174450001
    JONES, Sion Laurence
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Administrateur
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    United KingdomEnglish137554960001
    KNIGHT, Richard Daniel
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    Administrateur
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11 Welken House
    England
    United KingdomBritish162323970001
    MADDIN, Keith John
    27 Wayneflete Tower Avenue
    KT10 8QQ Esher
    Surrey
    Administrateur
    27 Wayneflete Tower Avenue
    KT10 8QQ Esher
    Surrey
    United KingdomBritish141926560001
    NUTTALL, Lennard Joseph
    90 Moss Lane
    BL1 6LY Bolton
    Administrateur
    90 Moss Lane
    BL1 6LY Bolton
    EnglandBritish51238440001
    OLDHAM, James William
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Administrateur
    Boundary House
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    UkBritish127121570001
    PAYNE, Richard William Norris
    Harland House
    Harland Way, Southborough
    TW4 0TQ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Harland House
    Harland Way, Southborough
    TW4 0TQ Tunbridge Wells
    Kent
    British77845170001
    RICHARDSON, Philip
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British81186940003
    SALISBURY, Nicholas William
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish4380320005
    SEDDON, Christopher John
    88 Roe Green
    Worsley
    M28 2RN Manchester
    Administrateur
    88 Roe Green
    Worsley
    M28 2RN Manchester
    United KingdomBritish3813770002
    TINDALL, Terence William
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish4380330001
    WHITAKER, Jack Leeming
    Highcroft Foxholes Road
    Horwich
    BL6 6AL Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    Highcroft Foxholes Road
    Horwich
    BL6 6AL Bolton
    Greater Manchester
    British24399020001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Equitix Healthcare Limited
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11
    England
    01 mars 2017
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleLimited Liability Partnership Act 2000
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06371955
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 déc. 2007
    Livré le 22 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road coulsden t/no SY47077 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 11 déc. 1998
    Livré le 29 déc. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    In retentions account number 40652857. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 11 déc. 1998
    Livré le 29 déc. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Account number 30440701. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 12 avr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road, coulsdon t/no. SY47077 and all buildings and fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0