EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03170995 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Sevendale House 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Greater Manchester United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ England à Sevendale House 3rd Floor, Suite 6C 5-7 Dale Street Manchester Greater Manchester M1 1JB le 06 nov. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Emma Margaret Clarke en tant que secrétaire le 16 oct. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Thomas Adams en tant que secrétaire le 16 oct. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 10-11 Welken House Charterhouse Square London EC1M 6EH England à 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ le 05 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Thomas Adams en tant que secrétaire le 12 oct. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gordon Neil Springett en tant que secrétaire le 12 oct. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Alistair Martin Gillespie en tant qu'administrateur le 05 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jennifer Louise Crouch en tant que directeur le 05 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 22 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Daniel Knight en tant que directeur le 01 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sion Laurence Jones en tant que directeur le 01 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Jennifer Louise Crouch en tant qu'administrateur le 01 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Arthur Would en tant qu'administrateur le 01 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Emma Margaret | Secrétaire | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | 251514980001 | |||||||
| GILLESPIE, Robert Alistair Martin | Administrateur | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | England | British | 230652780001 | |||||
| WOULD, Philip Arthur | Administrateur | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | England | British | 157945610001 | |||||
| ADAMS, David Thomas | Secrétaire | 120 Aldersgate Street EC1A 4JQ London 5th Floor England | 238967880001 | |||||||
| CROSSLEY, Hugh Barnabas | Secrétaire | Stonebridge House Wiveton NR25 7TP Holt Norfolk | British | 107284040001 | ||||||
| HANDLEY, David Michael | Secrétaire | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | British | 52899270001 | ||||||
| PINNINGTON, Ian Harry | Secrétaire | Shillingford Bucklow View Bowdon WA14 3JP Altrincham Cheshire | British | 11801040001 | ||||||
| SMITH, Jonathan Charles | Secrétaire | c/o King Sturge Finance Warwick Street W1B 5NH London 30 United Kingdom | British | 127121960001 | ||||||
| SPRINGETT, Gordon Neil | Secrétaire | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | 169292500001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| CHRITSTIE, Rory William | Administrateur | c/o King Sturge Finance Warwick Street W1B 5NH London 30 United Kingdom | United Kingdom | British | 152827480001 | |||||
| CROUCH, Jennifer Louise | Administrateur | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | England | British | 199682550001 | |||||
| HANDLEY, David Michael | Administrateur | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 52899270001 | |||||
| HARRIS, John David | Administrateur | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | England | British | 174333200001 | |||||
| JACKSON, Geoffrey Allan | Administrateur | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | United Kingdom | British | 79174450001 | |||||
| JONES, Sion Laurence | Administrateur | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | United Kingdom | English | 137554960001 | |||||
| KNIGHT, Richard Daniel | Administrateur | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | United Kingdom | British | 162323970001 | |||||
| MADDIN, Keith John | Administrateur | 27 Wayneflete Tower Avenue KT10 8QQ Esher Surrey | United Kingdom | British | 141926560001 | |||||
| NUTTALL, Lennard Joseph | Administrateur | 90 Moss Lane BL1 6LY Bolton | England | British | 51238440001 | |||||
| OLDHAM, James William | Administrateur | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | Uk | British | 127121570001 | |||||
| PAYNE, Richard William Norris | Administrateur | Harland House Harland Way, Southborough TW4 0TQ Tunbridge Wells Kent | British | 77845170001 | ||||||
| RICHARDSON, Philip | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 81186940003 | ||||||
| SALISBURY, Nicholas William | Administrateur | Barclays Bank Plc 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 4380320005 | |||||
| SEDDON, Christopher John | Administrateur | 88 Roe Green Worsley M28 2RN Manchester | United Kingdom | British | 3813770002 | |||||
| TINDALL, Terence William | Administrateur | 19 Oak Tree Close GU25 4JF Virginia Water Surrey | England | British | 4380330001 | |||||
| WHITAKER, Jack Leeming | Administrateur | Highcroft Foxholes Road Horwich BL6 6AL Bolton Greater Manchester | British | 24399020001 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitix Healthcare Limited | 01 mars 2017 | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 18 déc. 2007 Livré le 22 déc. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road coulsden t/no SY47077 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 11 déc. 1998 Livré le 29 déc. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions In retentions account number 40652857. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 11 déc. 1998 Livré le 29 déc. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Account number 30440701. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 mars 1996 Livré le 12 avr. 1996 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road, coulsdon t/no. SY47077 and all buildings and fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0