RIDERS FOR HEALTH
Vue d'ensemble
Nom de la société | RIDERS FOR HEALTH |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
Numéro de société | 03178605 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RIDERS FOR HEALTH ?
Adresse du siège social | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RIDERS FOR HEALTH ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour RIDERS FOR HEALTH ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 14 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 juin 2017 | 15 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | 4.70 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Drummonds Harborough Road Pitsford Northampton NN6 9AA à Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY le 11 juil. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2016 sans liste des membres | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joan Ryan en tant que directeur le 18 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gill James en tant que directeur le 15 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Robert Hocking en tant que directeur le 15 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Charles Male en tant que directeur le 17 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Naa-Aku Addo en tant que directeur le 14 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Barrie Maxwell Margetts en tant que directeur le 23 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2014 | 56 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2015 sans liste des membres | AR01 | |||||||||||
Nomination de Mr Christopher Gordon Read en tant qu'administrateur le 16 sept. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sir Robin William Miller le 16 déc. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael David Shipster en tant qu'administrateur le 16 sept. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Alan Huewen en tant que directeur le 16 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen James Parrish en tant que directeur le 16 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2013 | 53 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2014 sans liste des membres | 12 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Horsley en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RIDERS FOR HEALTH ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLEMAN, Andrea | Secrétaire | The Old Vicarage Daventry Road Norton NN11 5ND Daventry Northamptonshire | British | Field Support Director | 61470170001 | |||||
MARVEL, Ruth Barbara Louise | Administrateur | 319 Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House | England | British | Charity Director | 177139660001 | ||||
MILLER, Robin William, Sir | Administrateur | Glatton PE28 5RU Huntingdon Glatton House Cambridgeshire | England | British | Consultant | 147305510001 | ||||
MINOLI, Federico | Administrateur | 16 Via S.Stefano 40125 Bologna Italy | Italy | Italian | President And Ceo | 67574270002 | ||||
READ, Christopher Gordon | Administrateur | 319 Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House | United Kingdom | British | Head Of Business And Programme Management | 195234730001 | ||||
SHIPSTER, Michael David | Administrateur | 319 Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House | United Kingdom | British | Independent Consultant | 129597600001 | ||||
COLEMAN, Andrea | Secrétaire | The Old Vicarage Daventry Road Norton NN11 5ND Daventry Northamptonshire | British | 61470170001 | ||||||
COLEMAN, Andrea | Secrétaire | The Old Vicarage Daventry Road Norton NN11 5ND Daventry Northamptonshire | British | 61470170001 | ||||||
HINDLE, Christopher William | Secrétaire | 12 Hay Close Great Oakley NN18 8HX Corby Northamptonshire | British | 105382830001 | ||||||
TAYLOR, Peter Robert Lees | Secrétaire | The Bungalow Methersgate Sutton IP12 3JL Woodbridge Suffolk | British | 14633280002 | ||||||
ADDO, Naa-Aku | Administrateur | Harborough Road Pitsford NN6 9AA Northampton The Drummonds | United Kingdom | Ghanaian | Economist | 162783750001 | ||||
AKSLAND, Chuck | Administrateur | Windy Hill School Lane CV23 8RR Priors Marston Warwickshire | Us | Racing Team Manager | 68170580001 | |||||
BECHER-WICKES, James Nicholas | Administrateur | Waynebourne 65 Pelhams Walk KT10 8QA Esher Surrey | United Kingdom | British | Director | 8062710001 | ||||
CLEARY, James Alan | Administrateur | Riverside Cottage Mill End RG9 3AX Henley On Thames Oxfordshire | England | British | Director | 6278630001 | ||||
DAVIES, Linda Jane | Administrateur | 15 Rivermill Court Kneesworth Street SG8 7BH Royston Hertfordshire | Great Britain | British | Personal Assistant | 46979160001 | ||||
HOCKING, Paul Robert | Administrateur | Harborough Road Pitsford NN6 9AA Northampton The Drummonds | United Kingdom | British | Accountant | 39850670001 | ||||
HORSLEY, Richard Geoffrey Courtenay | Administrateur | Elliotts Farmhouse Adstone NN12 8DY Towcester Northamptonshire | England | British | Chartered Accountant | 83097700001 | ||||
HUEWEN, Keith Alan | Administrateur | Harborough Road Pitsford NN6 9AA Northampton The Drummonds | United Kingdom | British | Manager | 62117580005 | ||||
JAMES, Gill | Administrateur | Harborough Road Pitsford NN6 9AA Northampton The Drummonds | England | British | Manager | 182168830001 | ||||
KAMBA, Angeline Saziso | Administrateur | 3 Hogsback Lane PO BOX Bw 699 Borrowdale Zimbabwe | Zimbabwean | Retired | 63631910001 | |||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Administrateur | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | Director | 137285750001 | ||||
MACDONALD, Robin Alisdair Stuart | Administrateur | Maritime House Hook Park Road Warsash SO31 9HA Southampton Hampshire | British | Finance Director | 5814050002 | |||||
MALE, Stephen Charles | Administrateur | 32 Lincoln Close WS13 7SW Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | Product Manager | 68863650001 | ||||
MARGETTS, Barrie Maxwell, Dr | Administrateur | 125 Wilton Road SO15 5JQ Southampton Hampshire | United Kingdom | British | University Academic | 71880140001 | ||||
MCCULLOCH, Michael Cutler | Administrateur | New Oakbarn The Green Bledington OX7 6XQ Chipping Norton | England | British | None | 78859310001 | ||||
PARRISH, Stephen James | Administrateur | Apartment 13 Victoria Gardens Victoria Road IM2 4BX Douglas Isle Of Man | United Kingdom | British | Motor Racing Driver | 186724010002 | ||||
PITTS TUCKER, Nicholas Andrew | Administrateur | Temple Court 11 Queen Victoria Street EC4N 4TA London | United Kingdom | British | Banker | 111117540001 | ||||
RICHARDS, Peter Gerald | Administrateur | Conifer House Lamborough Hill Wootton OX13 6BY Oxford Oxfordshire | England | British | Neurosurgeon | 318059150001 | ||||
RYAN, Joan Marie | Administrateur | 17 Old Park Avenue EN2 6PJ Enfield Middlesex | United Kingdom | British | Consultant | 62334490002 | ||||
SPEIGHT, Christopher | Administrateur | 64 Marle Road Raumarais Park 2090 FOREIGN Republic Of South Africa | British | Co Md | 62883660001 | |||||
TAYLOR, David George | Administrateur | 213 Erith Road DA7 6HR Bexleyheath Kent | British | Lecturer | 46979180001 |
RIDERS FOR HEALTH a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Créé le 21 déc. 2000 Livré le 09 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee but limited to £76,000 plus interest discount commission and other lawful charges and expenses and other monies provided for in the mortgage | |
Brèves mentions Property k/a plot 10 rivendell lang farm daventry northants. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
RIDERS FOR HEALTH a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0