MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03179118
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Point 3 Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DEERHAND LIMITED27 mars 199627 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 sept. 2009

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    11 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages244

    Comptes annuels établis au 31 mars 2004

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages244

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Qui sont les dirigeants de MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DONALDSON, Craig George
    35 Fellows Road
    NG9 1AQ Beeston
    Nottingham
    Secrétaire
    35 Fellows Road
    NG9 1AQ Beeston
    Nottingham
    British79026210001
    DONALDSON, Craig George
    35 Fellows Road
    NG9 1AQ Beeston
    Nottingham
    Administrateur
    35 Fellows Road
    NG9 1AQ Beeston
    Nottingham
    United KingdomBritishChartered Secretary79026210001
    SMITH, Kevin David
    23 The Parchments
    WS13 7NA Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    23 The Parchments
    WS13 7NA Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Secretary55604670001
    BRITTON, Jeanette Eden
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    Secrétaire
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    British33976690001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Secrétaire
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    BritishCompany Secretary77617710001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant8142960002
    SCHICKLING, John Joseph
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    75042900002
    SKELLY, Mary Angela
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    Secrétaire
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    British83455820001
    EXCELLET INVESTMENTS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Secrétaire
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    1872620003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ANDREEN, Marcus
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    Administrateur
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    SwedishSolicitor44488170001
    BUTLER, Thomas Michael
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    Administrateur
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    BritishCompany Director24904420001
    CARPENTER, Peter Jon
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    Administrateur
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    BritishCompany Director37632220001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Administrateur
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritishManaging Director79087670001
    CLINE, James Michael
    772 North Street
    Greenwich
    Connecticut
    06831
    Usa
    Administrateur
    772 North Street
    Greenwich
    Connecticut
    06831
    Usa
    AmericanInvestments119424160001
    DAYA, Moez Rajabali Rahemtulla
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    Administrateur
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    KenyaEngineering Consultant7644560001
    DENNING, Steven Aaron
    16 Khakum Drive
    Greenwich
    Connecticut
    Usa 06831
    Administrateur
    16 Khakum Drive
    Greenwich
    Connecticut
    Usa 06831
    United StatesAmericanInvestments62745230002
    HARDYMON, Gene Felda
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    Administrateur
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    AmericanPartner Venture Capital62278260001
    HARRIS, Paul
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    Administrateur
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    BritishAccountant68547980001
    IBRAHIM, Mohamed Fathi Ahmed, Doctor
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    Administrateur
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    BritishTelecom Consultant72245030003
    JULIN, Sven Tomas
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    SwedishCompany Director47715430001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    BritishCompany Secretary77617710001
    MACGOWAN, Iain Angus William
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    Administrateur
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    BritishSolicitor68985510001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant8142960002
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Secretary445360034
    RUDGE, Alan, Sir
    The Thatched Cottage
    North Weirs
    SO42 7QA Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    The Thatched Cottage
    North Weirs
    SO42 7QA Brockenhurst
    Hampshire
    BritishCompany Director65306740003
    SMITH, Julian Matthew
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    Administrateur
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    BritishAccountant110194190001
    VAN DEN BOOG, Louis Theodoor
    Amsteldijk Noord 119
    Nl-1183 Tj Amstelveen
    Netherlands
    Administrateur
    Amsteldijk Noord 119
    Nl-1183 Tj Amstelveen
    Netherlands
    DutchPrivate Investor53946680001
    VON BELL, Hans
    Grenvagen 32b
    Tyreso
    FOREIGN S 13552
    Sweden
    Administrateur
    Grenvagen 32b
    Tyreso
    FOREIGN S 13552
    Sweden
    SwedishAccountant66670210001
    WHENT, Gerald Arthur, Sir
    Raffin Stud
    West Soley Chilton Foliat
    RG17 0TN Hungerford
    Berkshire
    Administrateur
    Raffin Stud
    West Soley Chilton Foliat
    RG17 0TN Hungerford
    Berkshire
    BritishDeputy Chairman72227530001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    QUICKNESS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Administrateur
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    47109420002

    MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security over shares agreement
    Créé le 30 juil. 2003
    Livré le 06 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest from time to time in and to the shares all dividends interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transactions
    • 06 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security trust and intercreditor deed
    Créé le 19 mai 2003
    Livré le 05 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    If any intra-group creditor receives any sum in relation to any intra-group liability other than pursuant to clause 9.5 of the deed, that sum shall be promptly paid to the security trustee for application in accordance with the terms of the deed, and pending such payment it shall be held on trust for the security trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An australian asset fixed and floating charge
    Créé le 19 mai 2003
    Livré le 04 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transactions
    • 04 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A debenture between the companies (including the chargor) and the law debenture trust corporation P.L.C. as security trustee for the secured creditors
    Créé le 19 mai 2003
    Livré le 02 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all of its right title and interest from time to time and to each of the following assets: the schedule 4 real property; the tangible moveable property; any goodwill; all rights in relation to the uncalled capital; the shares, all dividends, interest and other monies; all monetary claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transactions
    • 02 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 oct. 1999
    Livré le 28 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from metapath software international, inc., Metapath software international (bellevue), inc., Metapath software international (dallas), inc. And metapath software international limited to the chargee under a facility document as defined in the guarantee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Greyrock Capital
    Transactions
    • 28 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 mars 2010Dissolved on
    30 sept. 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robin Arthur Ellis
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.
    practitioner
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0