CLICK TV LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CLICK TV LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03179628 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CLICK TV LIMITED ?
| Adresse du siège social | Chiswick Green 610 Chiswick High Road W4 5RU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CLICK TV LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour CLICK TV LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Melissa Sterling en tant que secrétaire le 23 janv. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Ms Anna Maria Redin en tant qu'administrateur le 11 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Yong-Nam Mathias Hermansson en tant que directeur le 11 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Emma Marie Bjurman en tant qu'administrateur le 01 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Beeston en tant que directeur le 06 août 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jens Kristoffer Eriksson en tant que directeur le 30 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Melissa Sterling en tant que secrétaire le 31 août 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Melissa Sterling en tant que secrétaire le 01 juil. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Jakob Mejlhede en tant qu'administrateur le 15 mai 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Chris Barton Pye en tant que directeur le 15 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan William Courtis Searle en tant que secrétaire le 30 juin 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan William Courtis Searle en tant que directeur le 30 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Jens Kristoffer Eriksson en tant qu'administrateur le 02 juil. 2014 | AP01 | |||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bengt Patrick Svensk en tant que directeur le 02 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CLICK TV LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STERLING, Melissa | Secrétaire | Chandos Place WC2N 4HG London 62 - 65 England | 223061200001 | |||||||
| BJURMAN, Emma Marie | Administrateur | Nice Entertainment Frihamnsgatan 11556 Stockholm 28 Sweden | Sweden | Swedish | 213718530001 | |||||
| FOX, Jeremy Simon | Administrateur | Chandos Place WC2N 4HG London 62-65 United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | 101506410001 | |||||
| MEJLHEDE, Jakob | Administrateur | 610 Chiswick High Road W4 5RU London Chiswick Green | England | Danish | 197849300001 | |||||
| REDIN, Anna Maria | Administrateur | Skeppsbron 18 111 30 Stockholm Mtg Sweden | Sweden | Swedish | 219537210001 | |||||
| FOX, Jeremy Simon | Secrétaire | 11 Parliament Hill NW3 2SY London | United Kingdom | 101506410001 | ||||||
| JACKSON, Jonathan Christopher | Secrétaire | c/o Digital Rights Group Chandos Place WC2N 4HG London 62-65 England | 160439300001 | |||||||
| KIRBY, Robert | Secrétaire | 610 Chiswick High Road W4 5RU London Chiswick Green England | 172334410001 | |||||||
| PROTHEROE, Ann | Secrétaire | 15 University Mansions Lower Richmond Road SW15 1EP London | British | 95090130001 | ||||||
| SEARLE, Jonathan William Courtis | Secrétaire | 610 Chiswick High Road W4 5RU London Chiswick Green England | 181966150001 | |||||||
| STERLING, Melissa | Secrétaire | Chandos Place WC2N 4HG London 65 England | 200052450001 | |||||||
| C H REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | 35 Old Queen Street SW1H 9JD London | 39694450001 | |||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| BEESTON, Richard | Administrateur | Chiswick High Road W4 5RU London Viasat Broadcasting Uk Ltd 610 United Kingdom | United Kingdom | British | 140875470001 | |||||
| DEBOER II, Louis | Administrateur | 25 Central Park West New York Ny10023 FOREIGN Usa | American | 63892320001 | ||||||
| DEVEREUX, Robert Harold Ferrers | Administrateur | 5 Ladbroke Terrace W11 3PG London | England | British | 68747470001 | |||||
| ERIKSSON, Jens Kristoffer | Administrateur | Frihamnsgatan 28 11556 Stockholm 28 Sweden | Sweden | Swedish | 189305710001 | |||||
| FOX, Jeremy Simon | Administrateur | 11 Parliament Hill NW3 2SY London | United Kingdom | United Kingdom | 101506410001 | |||||
| FOX, Paul Leonard, Sir | Administrateur | 20 The Rose Walk WD7 7JS Radlett Hertfordshire | British | 7691960001 | ||||||
| HERMANSSON, Yong-Nam Mathias | Administrateur | Box 2094 Stockholm Modern Times Group Mtg Ab 103 13 Sweden | Sweden | Swedish | 179474460001 | |||||
| IBBETT, Kenneth Richard Andre | Administrateur | 31 Aldridge Road Villas W11 1BN London | United Kingdom | British | 34929900001 | |||||
| JACKSON, Jonathan Christopher | Administrateur | 610 Chiswick High Road W4 5RU London Chiswick Green England | England | British | 77844330002 | |||||
| JENNINGS, Carolyn Susan | Administrateur | 35 Old Queen Street SW1H 9JD London | British | 7967610001 | ||||||
| KAWASH, Anmar Jeremy | Administrateur | 610 Chiswick High Road W4 5RU London Chiswick Green England | England | British | 154929030001 | |||||
| MEEK, Kingsley John Neville | Administrateur | 24 Church Vale N2 9PA London | United Kingdom | British | 37016140002 | |||||
| PROTHEROE, Ann | Administrateur | 15 University Mansions Lower Richmond Road SW15 1EP London | British | 95090130001 | ||||||
| PYE, Chris Barton | Administrateur | Brooks Road W4 3BJ London 3 Cope Studios Uk | United Kingdom | British | 179791340001 | |||||
| SEARLE, Jonathan William Courtis | Administrateur | Chiswick Green 610 Chiswick High Road W4 5RU London Viasat Broadcasting Uk Ltd Uk | United Kingdom | British | 131420990001 | |||||
| SVENSK, Bengt Patrick | Administrateur | Magasin 3 Frihamnsgatan 28 Stockolm Mgt Studios 115 99 Sweden | Sweden | Swedish | 179488050001 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLICK TV LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Times Group Mtg Limited | 06 avr. 2016 | 610 Chiswick High Road W4 5RU London Chiswick Green England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CLICK TV LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 23 nov. 2007 Livré le 11 déc. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 23 nov. 2007 Livré le 11 déc. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 13 juin 2007 Livré le 28 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 11 janv. 2007 Livré le 01 févr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0