CLICK TV LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLICK TV LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03179628
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLICK TV LIMITED ?

    • Activités de distribution de programmes de télévision (59133) / Information et communication

    Où se situe CLICK TV LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Chiswick Green
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLICK TV LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VIRGIN CENTURY TELEVISION LIMITED30 avr. 199630 avr. 1996
    YOUNGMASTER LIMITED28 mars 199628 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de CLICK TV LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CLICK TV LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Ms Melissa Sterling en tant que secrétaire le 23 janv. 2017

    2 pagesAP03

    Nomination de Ms Anna Maria Redin en tant qu'administrateur le 11 mars 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Yong-Nam Mathias Hermansson en tant que directeur le 11 mars 2016

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Nomination de Ms Emma Marie Bjurman en tant qu'administrateur le 01 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Beeston en tant que directeur le 06 août 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jens Kristoffer Eriksson en tant que directeur le 30 juin 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Melissa Sterling en tant que secrétaire le 31 août 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 avr. 2016

    État du capital au 25 avr. 2016

    • Capital: GBP 1,368
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Nomination de Ms Melissa Sterling en tant que secrétaire le 01 juil. 2015

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Jakob Mejlhede en tant qu'administrateur le 15 mai 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Chris Barton Pye en tant que directeur le 15 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan William Courtis Searle en tant que secrétaire le 30 juin 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Jonathan William Courtis Searle en tant que directeur le 30 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2015

    État du capital au 17 avr. 2015

    • Capital: GBP 1,368
    SH01

    Nomination de Mr Jens Kristoffer Eriksson en tant qu'administrateur le 02 juil. 2014

    AP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Bengt Patrick Svensk en tant que directeur le 02 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2014

    État du capital au 01 avr. 2014

    • Capital: GBP 1,368
    SH01

    Qui sont les dirigeants de CLICK TV LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STERLING, Melissa
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62 - 65
    England
    Secrétaire
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62 - 65
    England
    223061200001
    BJURMAN, Emma Marie
    Nice Entertainment
    Frihamnsgatan
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    Administrateur
    Nice Entertainment
    Frihamnsgatan
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    SwedenSwedish213718530001
    FOX, Jeremy Simon
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    United Kingdom
    Administrateur
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    United Kingdom
    United KingdomUnited Kingdom101506410001
    MEJLHEDE, Jakob
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    Administrateur
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    EnglandDanish197849300001
    REDIN, Anna Maria
    Skeppsbron 18
    111 30 Stockholm
    Mtg
    Sweden
    Administrateur
    Skeppsbron 18
    111 30 Stockholm
    Mtg
    Sweden
    SwedenSwedish219537210001
    FOX, Jeremy Simon
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    Secrétaire
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    United Kingdom101506410001
    JACKSON, Jonathan Christopher
    c/o Digital Rights Group
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    England
    Secrétaire
    c/o Digital Rights Group
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    England
    160439300001
    KIRBY, Robert
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Secrétaire
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    172334410001
    PROTHEROE, Ann
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    Secrétaire
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    British95090130001
    SEARLE, Jonathan William Courtis
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Secrétaire
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    181966150001
    STERLING, Melissa
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    65
    England
    Secrétaire
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    65
    England
    200052450001
    C H REGISTRARS LIMITED
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Secrétaire
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    39694450001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BEESTON, Richard
    Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd 610
    United Kingdom
    Administrateur
    Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd 610
    United Kingdom
    United KingdomBritish140875470001
    DEBOER II, Louis
    25 Central Park West
    New York Ny10023
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    25 Central Park West
    New York Ny10023
    FOREIGN Usa
    American63892320001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Administrateur
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritish68747470001
    ERIKSSON, Jens Kristoffer
    Frihamnsgatan 28
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    Administrateur
    Frihamnsgatan 28
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    SwedenSwedish189305710001
    FOX, Jeremy Simon
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    Administrateur
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    United KingdomUnited Kingdom101506410001
    FOX, Paul Leonard, Sir
    20 The Rose Walk
    WD7 7JS Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 The Rose Walk
    WD7 7JS Radlett
    Hertfordshire
    British7691960001
    HERMANSSON, Yong-Nam Mathias
    Box 2094
    Stockholm
    Modern Times Group Mtg Ab
    103 13
    Sweden
    Administrateur
    Box 2094
    Stockholm
    Modern Times Group Mtg Ab
    103 13
    Sweden
    SwedenSwedish179474460001
    IBBETT, Kenneth Richard Andre
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    Administrateur
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    United KingdomBritish34929900001
    JACKSON, Jonathan Christopher
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Administrateur
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    EnglandBritish77844330002
    JENNINGS, Carolyn Susan
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Administrateur
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    British7967610001
    KAWASH, Anmar Jeremy
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Administrateur
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    EnglandBritish154929030001
    MEEK, Kingsley John Neville
    24 Church Vale
    N2 9PA London
    Administrateur
    24 Church Vale
    N2 9PA London
    United KingdomBritish37016140002
    PROTHEROE, Ann
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    Administrateur
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    British95090130001
    PYE, Chris Barton
    Brooks Road
    W4 3BJ London
    3 Cope Studios
    Uk
    Administrateur
    Brooks Road
    W4 3BJ London
    3 Cope Studios
    Uk
    United KingdomBritish179791340001
    SEARLE, Jonathan William Courtis
    Chiswick Green
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd
    Uk
    Administrateur
    Chiswick Green
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd
    Uk
    United KingdomBritish131420990001
    SVENSK, Bengt Patrick
    Magasin 3
    Frihamnsgatan 28
    Stockolm
    Mgt Studios
    115 99
    Sweden
    Administrateur
    Magasin 3
    Frihamnsgatan 28
    Stockolm
    Mgt Studios
    115 99
    Sweden
    SwedenSwedish179488050001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLICK TV LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    06 avr. 2016
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02228654
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CLICK TV LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ingenious Media Active Capital Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ingenious Media Active Capital Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 28 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ingenious Media Active Capital Limited
    Transactions
    • 28 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 11 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ingenious Media Active Capital Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0