PRESS SELECT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PRESS SELECT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03182407 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PRESS SELECT LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Broadgate EC2M 2QS London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PRESS SELECT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour PRESS SELECT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 28 déc. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Giles Harvey Roberts Richardson en tant qu'administrateur le 27 janv. 2017 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Low en tant que directeur le 27 janv. 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keir Murray Fawcus en tant que directeur le 14 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Roger Haworth en tant que directeur le 14 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Lacey en tant que secrétaire le 06 juin 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr John Roger Haworth en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Lacey en tant que directeur le 06 juin 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Wpp Group (Nominees) Limited en tant que secrétaire le 12 janv. 2015 | 3 pages | AP04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2014 au 31 déc. 2014 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PRESS SELECT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Secrétaire | Farm Street W1J 5RJ London 27 England |
| 80143770001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Giles Harvey Roberts | Administrateur | Broadgate EC2M 2QS London 1 | England | British | 224284590001 | |||||||||
| BANNER, Christopher | Secrétaire | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| BANNER, Christopher | Secrétaire | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| CROMACK, Andrew Michael | Secrétaire | 23 Knole Road ME5 8PJ Chatham Kent | British | 78040930001 | ||||||||||
| GRAEME, Dorothy May | Secrétaire désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||||||
| GULLIVER, John Keith | Secrétaire | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | British | 147777590001 | ||||||||||
| LACEY, Stephen | Secrétaire | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | 164062390001 | |||||||||||
| LOW, Peter | Secrétaire | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | 148751160001 | |||||||||||
| LOW, Peter | Secrétaire | Flat 5 186 St Johns Street EC1V 4JZ London | British | 65476890002 | ||||||||||
| OKORE, Maxwell | Secrétaire | 219 South Croxted Road SE21 8AY London | British | 23396630001 | ||||||||||
| STANNETT, Robert William | Secrétaire | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | British | 141063520001 | ||||||||||
| BANNER, Christopher | Administrateur | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| DOLTON, Stephen | Administrateur | 99 Cumnor Hill OX2 9JR Oxford | British | 70990450005 | ||||||||||
| FAWCUS, Keir Murray | Administrateur | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 84594470003 | |||||||||
| GRAEME, Lesley Joyce | Administrateur désigné | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||||||
| GULLIVER, John Keith | Administrateur | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | United Kingdom | British | 147777590001 | |||||||||
| HARKNESS, Peter Martin | Administrateur | 19 Horsley Court Montaigne Close Regency Street SW1 4BF London | United Kingdom | British | 146757430001 | |||||||||
| HAWORTH, John Roger | Administrateur | Broadgate EC2M 2QS London 1 | England | British | 91354480002 | |||||||||
| HILLIARD, Charles Stephen | Administrateur | 18 Albion Works Studios 63 Sigdon Road E8 1AW London | British | 104848990001 | ||||||||||
| KNIGHT, Martin | Administrateur | The Cuttings 57 Cheam Road East Ewell KT17 3EB Epsom Surrey | England | British | 13326400003 | |||||||||
| LACEY, Stephen | Administrateur | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 88368490002 | |||||||||
| LOW, Peter | Administrateur | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 65476890002 | |||||||||
| OKORE, Maxwell | Administrateur | 219 South Croxted Road SE21 8AY London | British | 23396630001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Jonathan Paul | Administrateur | 7 Hatton Close Chafford Hundred RM16 6RP Grays Essex | United Kingdom | British | 104848170001 | |||||||||
| STANLEY CLAMP, Richard | Administrateur | The Basement Flat 63 Belsize Avenue NW3 4QN London | British | 47274840001 | ||||||||||
| STANNETT, Robert William | Administrateur | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | England | British | 141063520001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PRESS SELECT LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precise Media Group Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
PRESS SELECT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 01 avr. 2005 Livré le 15 avr. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any chargor or other member of the group to the chargee (the "security trustee") as agent and trustee for itself and each of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 juil. 2001 Livré le 14 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 févr. 1999 Livré le 25 févr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all discounted debts and the other debts and all the companys rights under any supply contract giving rise to a discounted debt or other debt including all goods under any such contract together by way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0