PRESS SELECT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRESS SELECT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03182407
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRESS SELECT LIMITED ?

    • Autres activités de services d'information n.c.a. (63990) / Information et communication

    Où se situe PRESS SELECT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Broadgate
    EC2M 2QS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PRESS SELECT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour PRESS SELECT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 28 déc. 2018

    • Capital: GBP 10
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Giles Harvey Roberts Richardson en tant qu'administrateur le 27 janv. 2017

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Low en tant que directeur le 27 janv. 2017

    2 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mai 2016

    État du capital au 31 mai 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Keir Murray Fawcus en tant que directeur le 14 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Roger Haworth en tant que directeur le 14 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2015

    État du capital au 08 mai 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Stephen Lacey en tant que secrétaire le 06 juin 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Roger Haworth en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Lacey en tant que directeur le 06 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Wpp Group (Nominees) Limited en tant que secrétaire le 12 janv. 2015

    3 pagesAP04

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2014 au 31 déc. 2014

    3 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de PRESS SELECT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Secrétaire
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2757919
    80143770001
    RICHARDSON, Giles Harvey Roberts
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish224284590001
    BANNER, Christopher
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Secrétaire
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    British76044030002
    BANNER, Christopher
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Secrétaire
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    British76044030002
    CROMACK, Andrew Michael
    23 Knole Road
    ME5 8PJ Chatham
    Kent
    Secrétaire
    23 Knole Road
    ME5 8PJ Chatham
    Kent
    British78040930001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Secrétaire désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Secrétaire
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    British147777590001
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Secrétaire
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    164062390001
    LOW, Peter
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Secrétaire
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    148751160001
    LOW, Peter
    Flat 5
    186 St Johns Street
    EC1V 4JZ London
    Secrétaire
    Flat 5
    186 St Johns Street
    EC1V 4JZ London
    British65476890002
    OKORE, Maxwell
    219 South Croxted Road
    SE21 8AY London
    Secrétaire
    219 South Croxted Road
    SE21 8AY London
    British23396630001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Secrétaire
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    British141063520001
    BANNER, Christopher
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Administrateur
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    British76044030002
    DOLTON, Stephen
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    Administrateur
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    British70990450005
    FAWCUS, Keir Murray
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish84594470003
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Administrateur désigné
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Administrateur
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    United KingdomBritish147777590001
    HARKNESS, Peter Martin
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    Administrateur
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    United KingdomBritish146757430001
    HAWORTH, John Roger
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish91354480002
    HILLIARD, Charles Stephen
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    Administrateur
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    British104848990001
    KNIGHT, Martin
    The Cuttings 57 Cheam Road
    East Ewell
    KT17 3EB Epsom
    Surrey
    Administrateur
    The Cuttings 57 Cheam Road
    East Ewell
    KT17 3EB Epsom
    Surrey
    EnglandBritish13326400003
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish88368490002
    LOW, Peter
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish65476890002
    OKORE, Maxwell
    219 South Croxted Road
    SE21 8AY London
    Administrateur
    219 South Croxted Road
    SE21 8AY London
    British23396630001
    SHEPHERD, Jonathan Paul
    7 Hatton Close
    Chafford Hundred
    RM16 6RP Grays
    Essex
    Administrateur
    7 Hatton Close
    Chafford Hundred
    RM16 6RP Grays
    Essex
    United KingdomBritish104848170001
    STANLEY CLAMP, Richard
    The Basement Flat 63 Belsize Avenue
    NW3 4QN London
    Administrateur
    The Basement Flat 63 Belsize Avenue
    NW3 4QN London
    British47274840001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Administrateur
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    EnglandBritish141063520001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PRESS SELECT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Precise Media Group Holdings Limited
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    06 avr. 2016
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PRESS SELECT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 avr. 2005
    Livré le 15 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any chargor or other member of the group to the chargee (the "security trustee") as agent and trustee for itself and each of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 juil. 2001
    Livré le 14 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 févr. 1999
    Livré le 25 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all discounted debts and the other debts and all the companys rights under any supply contract giving rise to a discounted debt or other debt including all goods under any such contract together by way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank Cashflow Finance Limited
    Transactions
    • 25 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0