CONNAUGHT PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONNAUGHT PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03184319
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONNAUGHT PLC ?

    • (4525) /
    • (7415) /

    Où se situe CONNAUGHT PLC ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CONNAUGHT PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONNAUGHT HOLDINGS LIMITED29 mai 199629 mai 1996
    BONDCO 611 LIMITED11 avr. 199611 avr. 1996

    Quels sont les derniers comptes de CONNAUGHT PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour CONNAUGHT PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    21 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    20 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    19 pagesWU07

    Avis de révocation du liquidateur par le tribunal

    10 pagesWU14

    Nomination d'un liquidateur

    3 pagesWU04

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidators annual progress report to 24/02/2017
    17 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2015
    15 pagesLIQ MISC

    Changement d'adresse du siège social de Kpmg 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 08 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 25 févr. 2014

    25 pages2.24B

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    1 pages2.33B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 25 févr. 2014

    25 pages2.24B

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    25 pages2.33B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 déc. 2013

    24 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 déc. 2013

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 juin 2013

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 juin 2013

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 juin 2013

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 déc. 2012

    22 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 déc. 2012

    22 pages2.24B

    Qui sont les dirigeants de CONNAUGHT PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Secrétaire
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British140133020001
    HILL, Stephen Ronald
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Administrateur
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish115233060001
    ROSS, Timothy Stuart
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Administrateur
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    EnglandBritish33564830003
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Secrétaire
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Secrétaire
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    British64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Secrétaire
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    British99914770001
    WELLS, David Francis
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    Secrétaire
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    British104366980002
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Secrétaire désigné
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005060001
    ALCOCK, Robert Harding
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Administrateur
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish9764400003
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Administrateur
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritish99584240001
    DARKIN, Andrew
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    Administrateur
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    United KingdomBritish137575700001
    DAVIES, Mark Dingad
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Administrateur
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish203044250004
    EVANS, Terence Mervin
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    Administrateur
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    British47913740001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Administrateur
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Administrateur
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    MCLAUGHLIN, James, Mr.
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    Administrateur
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    UkBritish107447050001
    MCNAUGHTON, Andrew Robert Paul
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    Administrateur
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    British53282280004
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Administrateur
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    EnglandBritish64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritish99914770001
    PRICE, Caroline Fiona
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Administrateur
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritish38883480011
    SMITH, Richard David
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    Administrateur
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    British17374050001
    STANDING, Roger
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    Administrateur
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    British47913670001
    TINCKNELL, Mark William
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Administrateur
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish4088810003
    WELLS, David Francis
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    Administrateur
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    British104366980001
    WILLIAMS, Anthony John
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    Administrateur
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    British81797450001
    BONDLAW DIRECTORS LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Administrateur désigné
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005050001

    CONNAUGHT PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A mortgage of shares agreement
    Créé le 26 nov. 2009
    Livré le 01 déc. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First equitable mortgage all the shares.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Mortgage of shares agreement
    Créé le 14 nov. 2009
    Livré le 25 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares including all related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Mortgage of shares
    Créé le 14 nov. 2009
    Livré le 24 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first equitable mortgage all shares see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 24 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Rent deposit deed
    Créé le 15 sept. 2009
    Livré le 21 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    £1,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Bank deposit of £1,000.00.
    Personnes ayant droit
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transactions
    • 21 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of shares
    Créé le 06 août 2009
    Livré le 25 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transactions
    • 25 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Security agreement
    Créé le 06 août 2009
    Livré le 25 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transactions
    • 25 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Shares pledge
    Créé le 06 août 2009
    Livré le 26 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    Each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pledges and assigns to the security trustee its whole right title interest and benefit in and to the charged assets the shares being 100 shares of £1 each in the share capital of the company the dividends see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes
    Transactions
    • 26 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 23 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transactions
    • 23 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Share pledge
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 28 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its whole right, title interest and benefit in to the charged assets:the charged assets means the shares and all stocks being 100 ordinary shares of £1.00 each see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transactions
    • 28 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of shares
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 23 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transactions
    • 23 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Scottish shares pledge
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 25 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Whole right title and interest in and to the charged assets being the 100 ordinary shares of £1 each in connaught property services (glasgow) limited and the related rights. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transactions
    • 25 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of shares agreement
    Créé le 19 oct. 2007
    Livré le 31 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares and all interest in the shares including all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Share plegde agreement
    Créé le 21 août 2007
    Livré le 05 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and all stocks,shares,warrants,securitites,rights,money or property,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 05 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    A security agreement
    Créé le 17 août 2007
    Livré le 31 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    A mortgage of shares agreement
    Créé le 17 août 2007
    Livré le 31 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares owned by it (including all related rights). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 déc. 2006
    Livré le 16 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 sept. 2006
    Livré le 07 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,000.00 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    Charge of £1,000.00 deposit account and other monies due under a lease. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transactions
    • 07 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 mai 2004
    Livré le 20 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 20 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 21 août 2002
    Livré le 24 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such sums together with interest and other amounts accruing on such sums for the time being standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00899263 of the company with the chargee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 09 mai 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such sums together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061 of the company together with all the present and future right title and benefit of the company whatsoever in the deposit.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 28 mars 2002
    Livré le 13 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2000
    Livré le 22 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 10 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 01 juil. 1999
    Livré le 08 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account desingation 21213201 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 juin 1996
    Livré le 01 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CONNAUGHT PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 sept. 2010Administration started
    07 mars 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DateType
    17 sept. 2019Conclusion of winding up
    05 févr. 2014Petition date
    25 févr. 2014Commencement of winding up
    04 mars 2020Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Paul Nicholas Dumbell
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    practitioner
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0