CREDIT & MERCANTILE PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCREDIT & MERCANTILE PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03186787
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CREDIT & MERCANTILE PLC ?

    • Activités des sociétés de financement hypothécaire (64922) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CREDIT & MERCANTILE PLC ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO
    2 City Place Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CREDIT & MERCANTILE PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour CREDIT & MERCANTILE PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 16 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2017

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mai 2016

    État du capital au 07 mai 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 avr. 2015

    État du capital au 16 avr. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré C/O Bdo 2 City Place Beehive Ring Road London Gatwick Airport Gatwick West Sussex RH6 0PA

    1 pagesAD04

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The Grange Market Square Westerham Kent TN16 1HB United Kingdom à Charlewood House Blackberry Lane Lingfield Surrey RH7 6NG

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Susan Marilyn Winston le 06 avr. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Roy George Winston le 06 avr. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    18 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de The Grange Market Square Westerham Kent TN16 1HB à C/O Bdo 2 City Place Beehive Ring Road London Gatwick Airport Gatwick West Sussex RH6 0PA le 06 avr. 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Susan Marilyn Winston en tant qu'administrateur le 30 juin 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Brennan en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mai 2014

    État du capital au 02 mai 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Arthur Wolffsohn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Roy George Winston en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Arthur Wolffsohn en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Roy George Winston le 18 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Roy George Winston le 18 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CREDIT & MERCANTILE PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WINSTON, Roy George
    Domaine De Roqueville
    62/62bis, Bloc A2, 20 Blvd Princesse Charlette
    Monaco
    Domaine De Roqueville
    Mc98000
    Monaco
    Secrétaire
    Domaine De Roqueville
    62/62bis, Bloc A2, 20 Blvd Princesse Charlette
    Monaco
    Domaine De Roqueville
    Mc98000
    Monaco
    184059170001
    WINSTON, Roy George, Mr.
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    Administrateur
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    MonacoBritish31467850018
    WINSTON, Susan Marilyn
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    Administrateur
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    MonacoBritish192668540001
    NORMAN, John Thomas
    13 Pinewood Road
    Branksome Park
    BH13 6JP Poole
    Dorset
    Secrétaire
    13 Pinewood Road
    Branksome Park
    BH13 6JP Poole
    Dorset
    British17047090001
    WINSTON, Roy George
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Secrétaire
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    British31467850002
    WINSTON, Susan Marilyn
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Secrétaire
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    British13454610001
    WINSTON, Susan Marilyn
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Secrétaire
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    British13454610001
    WOLFFSOHN, Arthur Mervyn Jackson
    Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    32
    Surrey
    England
    Secrétaire
    Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    32
    Surrey
    England
    149725080001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Secrétaire désigné
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    BRENNAN, Stephen
    31 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    Administrateur
    31 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    United KingdomBritish206793910001
    MURPHY, Jeremiah Joseph
    Flat 1 67 Chatsworth Road
    NW2 4BG London
    Administrateur
    Flat 1 67 Chatsworth Road
    NW2 4BG London
    Irish80808560001
    RANSHAW, Colin Stuart
    73 Berkeley Court
    Oatlands Drive
    KT13 9HY Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    73 Berkeley Court
    Oatlands Drive
    KT13 9HY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish77945000001
    WINSTON, Susan Marilyn
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Administrateur
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    United KingdomBritish13454610001
    WOLFFSOHN, Arthur Mervyn Jackson
    32 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Administrateur
    32 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    EnglandBritish27451050001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    Bridge House
    181 Queen Victoria Street
    EC4V 4DZ London
    Administrateur
    Bridge House
    181 Queen Victoria Street
    EC4V 4DZ London
    38974750001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Administrateur désigné
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CREDIT & MERCANTILE PLC ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Roy George Winston
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Charlewood House
    England
    01 sept. 2016
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Charlewood House
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Monaco
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CREDIT & MERCANTILE PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over deposit
    Créé le 14 sept. 2010
    Livré le 21 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Under the terms of the charge with full title guarantee by way of fixed first charge its entire right, title and interest see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge over deposit
    Créé le 15 avr. 2009
    Livré le 18 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its entire right, title and interest in and to the deposit. All rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Sub charge
    Créé le 24 janv. 2007
    Livré le 27 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right, title, interest and benefit, present and future of the principal charge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 août 2006
    Livré le 23 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 07 avr. 2006
    Livré le 18 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right, title, interest and benefit under and in respect of the principal charge being a charge of all f/h property k/a 2 stag cottages, pheasants hill, hambleden t/n BM307515.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 22 mars 2006
    Livré le 01 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title interest and benefit present and future as beneficiary under and in respect of the principal charge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 10 mars 2006
    Livré le 15 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that l/h property known as flat 1 42 upper brook street london t/n NGL759764.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 10 févr. 2006
    Livré le 16 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that f/h/l/h property k/a 18 adams row and garage, london.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 09 févr. 2006
    Livré le 16 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right and benefit in respect of the principal charge of the l/h property known as flats 4 and 5, 1 shepherd street and 1 white horse street london t/n's NGL810644 and NGL815657,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 09 févr. 2006
    Livré le 16 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right and benefit in respect of the principal charge of the l/h property known as flats 2 and 3, 1 shepherd street and 1 white horse street london t/n's NGL810644 and NGL815657,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 09 févr. 2006
    Livré le 16 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right and benefit in respect of the principal charge of the l/h property known as flat 1, 1 shepherd street and 1 white horse street london t/n's NGL810644 and NGL815657,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 06 févr. 2006
    Livré le 14 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right, title, interest and benefit as beneficiary under and respect of the principal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 26 janv. 2006
    Livré le 03 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H trimpley house bewdley worcestershire t/no WR59126.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 20 janv. 2006
    Livré le 26 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and benefit present and future in respect of the principal charge being a charge of the l/h property known as flat 11 50 south audley street london t/n NGL600242.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 15 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the right, title, interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that freehold land adjacent to preston house, preston, woodleigh, kingsbridge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 15 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the right, title, interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that freehold land k/a preston house, preston, woodleigh, kingsbridge t/no DN371720.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 15 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the right, title, interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that freehold land at highthorn road and randerson drive, kilnhurst, rotherham t/nos SYK412506, SYK494552 and SYK486098.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 08 nov. 2005
    Livré le 15 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 112 high street,cricklade,swindon.t/n WT211883.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 08 nov. 2005
    Livré le 15 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 35 high street,malmesbury.t/n WT204006.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 08 nov. 2005
    Livré le 15 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 6 oxford street, malmesbury.t/n WT216468.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 08 nov. 2005
    Livré le 15 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 3 oxford street malmesbury t/no WT168415.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub charge
    Créé le 08 nov. 2005
    Livré le 15 nov. 2005
    En cours
    Transactions
    • 15 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Sub-charge
    Créé le 12 oct. 2005
    Livré le 15 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit present and future as beneficiary in respect under and in respect of the principal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 14 sept. 2005
    Livré le 17 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a woodberry down st marys road ascot berkshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sub-charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 09 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title interest and benefit under and in respect of the the principal charge being a charge of f/h property k/a marks tey hall london road colcheser t/no EX544960 and EX345426.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0