ETTON PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéETTON PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03187989
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ETTON PROPERTIES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction
    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe ETTON PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Beckside Court
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    East Yorkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ETTON PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    P. & A.M. WRIGHT (PROPERTIES) LIMITED19 avr. 199619 avr. 1996

    Quels sont les derniers comptes de ETTON PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ETTON PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2018

    7 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2018 au 31 oct. 2018

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de C/O a Macdonald and Co 21 Parliament Street Kingston upon Hull East Yorkshire HU1 2BL à Beckside Court Annie Reed Road Beverley East Yorkshire HU17 0LF le 09 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 avr. 2016

    État du capital au 20 avr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 avr. 2015

    État du capital au 27 avr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2014

    État du capital au 16 mai 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O a Macdonald and Co 21 Parliament Street Kingston upon Hull East Yorkshire HU1 2BL England* le 19 mai 2011

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Regents Court Princess Street Hull East Yorkshire HU2 8BA* le 19 mai 2011

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2010

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ETTON PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARDELL, John Michael
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    BritishChartered Accountant44804070002
    WRIGHT, Anne Marie
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    EnglandEnglishCompany Director7985770001
    WRIGHT, Michael Philip
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishBuilder80331480001
    WRIGHT, Philip
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director7678180001
    WRIGHT, Philip
    Beech Lodge
    104 Main Street, Etton
    HU17 7PQ Beverley
    The East Riding Of Yorkshire
    Secrétaire
    Beech Lodge
    104 Main Street, Etton
    HU17 7PQ Beverley
    The East Riding Of Yorkshire
    BritishCompany Director7678180001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ETTON PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Philip Wright
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mrs Anne Marie Wright
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Annie Reed Road
    HU17 0LF Beverley
    Beckside Court
    East Yorkshire
    England
    Non
    Nationalité: English
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    ETTON PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2006
    Livré le 07 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 23 févr. 2006
    Livré le 25 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at station road keyingham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juil. 2003
    Livré le 17 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land at the meadow westland way leven. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juil. 2003
    Livré le 17 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at freehold land at main street tickton. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juil. 2003
    Livré le 17 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land at plot 1 yapham road pocklington. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juil. 2003
    Livré le 17 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land at plot 2 yapham road pocklington. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 oct. 1996
    Livré le 15 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0