CALEDONIAN TANKER CO LTD
Vue d'ensemble
Nom de la société | CALEDONIAN TANKER CO LTD |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03191119 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CALEDONIAN TANKER CO LTD ?
Adresse du siège social | Eldon Court Percy Street NE99 1TD Newcastle Upon Tyne |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CALEDONIAN TANKER CO LTD ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour CALEDONIAN TANKER CO LTD ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Russell Kenneth Campbell le 16 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William Allan Plant le 16 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Barry Edward Kerr Gilmour le 16 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Russell Kenneth Campbell le 16 mai 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2008 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2007 | 9 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2006 | 9 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2005 | 9 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363s | ||||||||||
legacy | pages | 363(353) |
Qui sont les dirigeants de CALEDONIAN TANKER CO LTD ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL, Russell Kenneth | Secrétaire | Eldon Court Percy Street NE99 1TD Newcastle Upon Tyne | British | 26948290004 | ||||||
CAMPBELL, Russell Kenneth | Administrateur | Eldon Court Percy Street NE99 1TD Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Company Secretary | 26948290004 | ||||
GILMOUR, Barry Edward Kerr | Administrateur | Eldon Court Percy Street NE99 1TD Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Company Director | 20361920009 | ||||
PLANT, William Allan | Administrateur | Eldon Court Percy Street NE99 1TD Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Company Director | 87465680003 | ||||
CHRISTIAN, Kevin | Secrétaire | 12 Close Quane IM5 1PY Peel Isle Of Man | British | Chartered Accountant | 54761610001 | |||||
MAHONY, Peter John | Secrétaire | 8 Harlesden Road Harold Hill RM3 9HT Romford Essex | British | Company Sec | 31909050001 | |||||
STEVEN, Carol Anne | Secrétaire | Kaha Lani 21 Rocheid Park EH4 1RU Edinburgh Lothian | British | Secretary | 41784540001 | |||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
CHRISTIAN, Kevin | Administrateur | 7 Grove House The Grove Gosforth NE3 1NX Newcastle Upon Tyne | British | Chartered Accountant | 54761610002 | |||||
EWART, Philip Ian | Administrateur | 6 Darnell Road EH5 3PL Edinburgh | British | Company Director | 17367290001 | |||||
MACDONALD, Duncan Christopher | Administrateur | 27 Station Road EH30 9HZ South Queensferry West Lothian | British | Company Director | 17367300001 | |||||
MCLEAN, Robert Urquhart | Administrateur | 8 Hadrian Court Ponteland NE20 9JU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Director | 29101050002 | |||||
SHUTTLEWORTH, David Andrew | Administrateur | 158 Edge Hill Ponteland NE20 9JN Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Director | 67100520005 | |||||
THOMSON, William Andrew Charles | Administrateur | 24 Hermitage Drive EH10 6BY Edinburgh | United Kingdom | British | Ship Owner | 577610001 | ||||
WATKINS, David Tyrrell | Administrateur | Redheugh Tarset NE48 1NB Hexham Northumberland | United Kingdom | British | Company Director | 15566730001 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
CALEDONIAN TANKER CO LTD a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of adherence bound by the terms of a composite guarantee and debenture dated 13 september 1997 and | Créé le 16 juin 2003 Livré le 21 juin 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Third supplemental deed | Créé le 14 févr. 1997 Livré le 28 févr. 1997 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letters (as defined) or the documents (as defined) | |
Brèves mentions All rights,title and interest in and to the assigned property,I.E.all sums of money paid pursuant to any of the relevant contracts with all benefits. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental deed | Créé le 06 juin 1996 Livré le 20 juin 1996 | En cours | Montant garanti The outstanding indebtedness being all sums outstanding at the relevant time (whether in respect of principal, interest or otherwise) due from the company to the chargee under the facility letters (as defined) or the security documents (as defined) | |
Brèves mentions Edinburgh fruid official 359110 and the insurances, earnings, the requisition compensation, the income and the ancillary charged account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0