WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03191608 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | First Floor, 2 Kingdom Street Paddington W2 6BD London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 avr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2026 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 16 déc. 2025
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Gillian Chamberlain en tant qu'administrateur le 21 nov. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Norman Webster en tant que directeur le 31 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 45 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Corinne Ripoche Van Hecke le 30 sept. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Capita Group Secretary Limited le 18 nov. 2024 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des détails de Capita Life & Pensions Regulated Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 nov. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 65 Gresham Street London EC2V 7NQ England à First Floor, 2 Kingdom Street Paddington London W2 6BD le 18 nov. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes complets modifiés jusqu'au 31 déc. 2023 | 43 pages | AAMD | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 44 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Charles Clements en tant que directeur le 13 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Billingham en tant que directeur le 21 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mark Norman Webster en tant qu'administrateur le 22 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 39 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Charles Clements en tant qu'administrateur le 07 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mark Billingham en tant qu'administrateur le 01 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Richard Coventry en tant que directeur le 02 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Antony Paul Brown en tant que directeur le 02 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England |
| 135207160001 | ||||||||||
| CHAMBERLAIN, Gillian | Administrateur | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England | Ireland | Irish | 338991880001 | |||||||||
| RIPOCHE VAN HECKE, Corinne | Administrateur | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England | England | French | 307636900002 | |||||||||
| VANOVERSCHELDE, Tom Frans | Administrateur | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England | England | Belgian | 258250350001 | |||||||||
| ARNOLD, Katy Jane | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 192234840001 | |||||||||||
| ELLERTON, David Mark | Secrétaire | 7 Torr Bridge Park Yealmpton PL8 2JF Plymouth Devon | British | 56498300001 | ||||||||||
| LEWIS, Michael George | Secrétaire | 11 Cunliffe Avenue PL9 9TL Plymouth Devon | British | 63553970002 | ||||||||||
| MCKEOWN, Brona Rose | Secrétaire | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | 193733110001 | |||||||||||
| MOSS, Susan | Secrétaire | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | 165094190001 | |||||||||||
| SQUIRES, Paul | Secrétaire | 295 Saltash Road Keyham PL2 2DG Plymouth Devon | British | 48985710001 | ||||||||||
| TRAHAIR, Julian | Secrétaire | Treluggan Landrake PL12 5ES Saltash Cornwall | British | 77945720001 | ||||||||||
| WHITEHEAD, David Clive | Secrétaire | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | 196683030001 | |||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| AITKEN, Stephen | Administrateur | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British,Australian | 188712540001 | |||||||||
| ALTHAM, Richard David | Administrateur | c/o C/O Governance Department Corporation Street 5th Floor M60 4ES Manchester New Century House | United Kingdom | British | 146408190001 | |||||||||
| BAYLEY, Trevor John | Administrateur | Woodside Clay Lake Endon ST9 9DD Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 804490002 | |||||||||
| BEDFORD, Nicolas Norman | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 147404780001 | |||||||||
| BILLINGHAM, Mark | Administrateur | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 295512650001 | |||||||||
| BOOTH, Harold Robert | Administrateur | 2 The Rowans St Mellion Park PL12 6UT Saltash Cornwall | England | British | 63554160001 | |||||||||
| BROWN, Antony Paul | Administrateur | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | United Kingdom | British | 200788860002 | |||||||||
| CARRIE, David Ross | Administrateur | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | England | United Kingdom | 55711250001 | |||||||||
| CARSON, Paul William | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England | United Kingdom | British | 182299470001 | |||||||||
| CLEMENTS, Christopher Charles | Administrateur | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 251947500001 | |||||||||
| CLEMENTS, Karen Suzanne | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 160392210001 | |||||||||
| COVENTRY, Ian Richard | Administrateur | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 262851910001 | |||||||||
| DALE, Ian Michael | Administrateur | The Moneycentre Drake Circus PL1 1QH Plymouth Devon | England | British | 137640110001 | |||||||||
| DALE, Ian Michael | Administrateur | Harding Grove ST15 8GT Stone 14 Staffordshire | England | British | 137640110001 | |||||||||
| FRANKLIN, Timothy Alan | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | Uttoxeter | British | 82709500001 | |||||||||
| GARLICK, Philip Michael | Administrateur | c/o C/O Julian Trahair Drakes Circus PL1 1QH Plymouth The Moneycentre Devon England | United Kingdom | British | 151356580001 | |||||||||
| GODDARD, Richard Thomas | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 63087570001 | |||||||||
| GOSLING, Clare Louise | Administrateur | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 204863170001 | |||||||||
| GREEN, Peter John | Administrateur | Park Cottage Askham Richard YO23 3QP York | British | 92728760001 | ||||||||||
| GREGORY, Gerald Arthur | Administrateur | Gatepiece House Quarry Bank DE4 3LF Matlock Derbyshire | England | British | 31843730001 | |||||||||
| HILLON, James | Administrateur | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | United Kingdom | British | 170882350001 | |||||||||
| HUDSON, Desmond Gerard | Administrateur | Lindale Off Lampson Road G63 9PD Killearn | United Kingdom | British | 32094360003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WESTERN MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capita Life & Pensions Regulated Services Limited | 07 mai 2021 | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Capita Financial Services Holdings Limited | 12 sept. 2017 | Gresham Street EC2V 7NQ London 65 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Capita International Financial Services Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham The Registry Kent United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0